INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED

INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINFRACARE (MIDLANDS) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04644802
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o G4S SPV
    Challenge House International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2025
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 ene 2027
    Próxima declaración de confirmación vence15 ene 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta01 ene 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Christopher Edwin Walker como director el 14 oct 2025

    2 páginasAP01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2024

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Andrew Philip Holland como secretario el 07 oct 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Georgina Claire Brown como secretario el 07 oct 2024

    1 páginasTM02

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2023

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2022

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Giles James Frost como director el 19 dic 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Hugh Luke Blaney como director el 19 dic 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Gregory Minion como director el 01 nov 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Charlotte Sophie Ellen Douglass como director el 27 sept 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Daniel Marinus Maria Vermeer como director el 27 sept 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Darch como director el 06 sept 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2021

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Georgina Claire Brown como secretario el 06 sept 2021

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Andrew Philip Holland como secretario el 03 sept 2021

    1 páginasTM02

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2020

    3 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Philip Holland como secretario el 01 mar 2021

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Daniel Peter Bevan como secretario el 01 mar 2021

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Stephen Gregory Minion como director el 27 jun 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOLLAND, Andrew Philip
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Secretario
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    328138910001
    ANDREWS, Paul Simon
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3 More London Riverside
    England
    Director
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3 More London Riverside
    England
    EnglandBritish119057120007
    BLANEY, Hugh Luke
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    Director
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    EnglandIrish79556770059
    COOK, Allan Cameron
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3 More London Riverside
    England
    Director
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3 More London Riverside
    England
    United KingdomBritish125405420001
    DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Director
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    United KingdomBritish245967540001
    FROST, Giles James
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    Director
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    United KingdomBritish81910810001
    WALKER, Christopher Edwin
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Director
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    United KingdomBritish267835110001
    BEVAN, Daniel Peter
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Secretario
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    253207550001
    BROWN, Georgina Claire
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Secretario
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    286948120001
    HOLLAND, Andrew Philip
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Secretario
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    280348430001
    POLLARD, Carolyn Jane
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Secretario
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    204165900001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BEVAN BRITTAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    35 Colston Avenue
    BS1 4TT Bristol
    Avon
    Secretario corporativo
    35 Colston Avenue
    BS1 4TT Bristol
    Avon
    101542850001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLANEY, Hugh Luke
    10 Dunmore Road
    Wimbledon
    SW20 8TN London
    Director
    10 Dunmore Road
    Wimbledon
    SW20 8TN London
    United KingdomIrish79556770002
    CARROLL, Paul Bryan
    The Brew House
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    Assura Group Limited
    United Kingdom
    Director
    The Brew House
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    Assura Group Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish85123780001
    DARCH, Richard
    Upper Borough Walls
    BA1 1RG Bath
    Archus Limited, Northgate House
    England
    Director
    Upper Borough Walls
    BA1 1RG Bath
    Archus Limited, Northgate House
    England
    EnglandBritish178693100001
    DARCH, Richard
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish178693100001
    DARCH, Richard
    Beaufort House
    London Road
    BA1 6PZ Bath
    Avon
    Director
    Beaufort House
    London Road
    BA1 6PZ Bath
    Avon
    EnglandBritish88696540001
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Director
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British13332510001
    DYER, Matthew Stephen
    43 Wentworth Road
    Harborne
    B17 9SN Birmingham
    West Midlands
    Director
    43 Wentworth Road
    Harborne
    B17 9SN Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish127210860001
    EBSWORTH, Martin Richard
    116 Harrow Road
    NG8 1FN Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    116 Harrow Road
    NG8 1FN Nottingham
    Nottinghamshire
    British119584110001
    FROST, Giles James
    Gorst Road
    SW11 6JB London
    21
    Director
    Gorst Road
    SW11 6JB London
    21
    United KingdomBritish81910810001
    HARTSHORNE, David John Morice
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish87382740001
    HATHAWAY, James Andrew John
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Director
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    EnglandBritish129270110001
    HOLMES, Jonathan
    9 Holly Close
    Farnham Common
    SL2 3QT Slough
    Director
    9 Holly Close
    Farnham Common
    SL2 3QT Slough
    EnglandBritish107261280002
    HOOD, John
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    Director
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    British39644740001
    MCPHERSON, Andrew Robert
    3 Lymmbrook House
    Whitbarrow Road
    WA13 9A Lymm
    Cheshire
    Director
    3 Lymmbrook House
    Whitbarrow Road
    WA13 9A Lymm
    Cheshire
    British98108070001
    MINION, Stephen Gregory
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Director
    c/o G4s Spv
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    United KingdomBritish201775990001
    MINION, Stephen Gregory
    Stomp Road
    Burnham
    SL1 7LW Slough
    The Priory
    Berkshire
    Director
    Stomp Road
    Burnham
    SL1 7LW Slough
    The Priory
    Berkshire
    EnglandBritish40537330005
    PAPE, Christopher Robert Crawford
    8 High Bannerdown
    Batheaston
    BA1 7JY Bath
    North East Somerset
    Director
    8 High Bannerdown
    Batheaston
    BA1 7JY Bath
    North East Somerset
    British97813200001
    PARKER, David
    4 Littledown Avenue
    BH7 7AN Bournemouth
    Dorset
    Director
    4 Littledown Avenue
    BH7 7AN Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish70697550001
    POKORA, David Bernard
    30 Pitchens End
    SN4 9PR Broad Hinton
    Wiltshire
    Director
    30 Pitchens End
    SN4 9PR Broad Hinton
    Wiltshire
    United KingdomBritish63190500001
    RAWLINGS, Nigel Keith
    18 Hollin Lane
    SK9 4JH Styal
    Cheshire
    Director
    18 Hollin Lane
    SK9 4JH Styal
    Cheshire
    EnglandBritish7127460001
    SAVAGE, Mark James
    23 Godwin Drive
    Nailsea
    BS48 2XE Bristol
    Avon
    Director
    23 Godwin Drive
    Nailsea
    BS48 2XE Bristol
    Avon
    British96884460001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1 Barnes Wallis Court
    England
    22 ene 2017
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1 Barnes Wallis Court
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05017735
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    10-11 Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    Welken House
    England
    22 ene 2017
    10-11 Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    Welken House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro08778370
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0