THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP

THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 04667322
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    • Actividades de atención residencial para personas mayores y discapacitadas (87300) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    Dirección de la sede social
    Eyre Court
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE MILTON KEYNES CARE PARTNERSHIP17 feb 200317 feb 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el28 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el28 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta02 feb 2027
    Próxima declaración de confirmación vence16 feb 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta02 feb 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025

    25 páginasAA

    Nombramiento de Ms Catherine Alice Kelly como director el 01 abr 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philippa Spratley como director el 31 mar 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    26 páginasAA

    Nombramiento de Miss Hilary Elizabeth Morris como director el 22 mar 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Anthony Stredder como director el 22 mar 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Daniel Hayes el 05 feb 2024

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Joanna Carole Downing el 05 feb 2024

    1 páginasCH03

    Modification des détails de Orders of St Johns Care Trust en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 feb 2024

    2 páginasPSC05

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    26 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Julian Lee como director el 01 jun 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kerry Margaret Dearden como director el 31 may 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul Cook como director el 22 mar 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Hill como director el 01 may 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Ronald Bolt como director el 30 abr 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Anna Clare Humphries como director el 21 mar 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Anthony Stredder como director el 03 mar 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Mildred Maria Elisabeth Wentworth-Stanley como director el 02 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    26 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Des Roches Square Witney Oxfordshire OX28 4BE England a Eyre Court Whisby Way Lincoln LN6 3LQ el 04 oct 2021

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DOWNING, Joanna Carole
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Secretario
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    257864410001
    COOK, Paul
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    EnglandBritish308898950001
    HAYES, Daniel
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    United KingdomBritish174967940001
    HILL, Richard
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    EnglandBritish158076770002
    KELLY, Catherine Alice
    Bedford Heights
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bpha
    England
    Director
    Bedford Heights
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bpha
    England
    EnglandBritish290955430001
    LEE, Mark Julian
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    EnglandBritish309710890001
    MORRIS, Hilary Elizabeth
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    EnglandBritish321239160001
    PEARCE, Julian Alexander
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    EnglandBritish275152490001
    WARDLE, Tracey
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    United KingdomBritish163494080001
    FREEMAN, Benjamin Patrick
    Horne Lane
    MK40 1NY Bedford
    Pilgrims House
    Beds
    England
    Secretario
    Horne Lane
    MK40 1NY Bedford
    Pilgrims House
    Beds
    England
    154577370001
    GRAY, Paul
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    England
    Secretario
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    England
    167606590001
    HARTLEY, Michael Jon
    Kingfishers
    Green Lane Prestwood
    HP16 0QA Great Missenden
    Buckinghamshire
    Secretario
    Kingfishers
    Green Lane Prestwood
    HP16 0QA Great Missenden
    Buckinghamshire
    British104158540001
    JOHNSON, Mark Andrew
    35 Waller Road
    Telegraph Hill
    SE14 5LE London
    Secretario
    35 Waller Road
    Telegraph Hill
    SE14 5LE London
    British91663210001
    BOLT, Kevin Ronald
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    United KingdomBritish127710580001
    BOULTER, Janet Elizabeth
    Des Roches Square
    OX28 4BE Witney
    1
    Oxfordshire
    England
    Director
    Des Roches Square
    OX28 4BE Witney
    1
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritish100644030003
    BURNS, Graham
    138 Offord Road
    N1 1PF London
    Director
    138 Offord Road
    N1 1PF London
    United KingdomBritish80006320001
    CHAMBERS, Antony Craven
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    Director
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish94516690001
    CHEESBROUGH, Andrew
    Wellingore Hall
    Wellingore
    LN5 0HX Lincoln
    The Orders Of St John Care Trust
    England
    Director
    Wellingore Hall
    Wellingore
    LN5 0HX Lincoln
    The Orders Of St John Care Trust
    England
    EnglandBritish174644360001
    CROSS, John William
    34 Church Lane
    MK44 1HR Sharnbrook
    Bedfordshire
    Director
    34 Church Lane
    MK44 1HR Sharnbrook
    Bedfordshire
    United KingdomBritish49654070004
    DEARDEN, Kerry Margaret
    Des Roches Square
    OX28 4BE Witney
    1
    England
    Director
    Des Roches Square
    OX28 4BE Witney
    1
    England
    EnglandBritish212395450001
    GOODSON, Frederick Brian, Rear Admiral
    Wellingore
    LN5 0HX Lincoln
    Wellingore Hall
    Director
    Wellingore
    LN5 0HX Lincoln
    Wellingore Hall
    EnglandBritish87097210001
    GRAY, Paul Lawrence
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    England
    Director
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    England
    EnglandBritish44869860001
    GREGORY, Fiona Estelle
    Horne Lane
    MK40 1NY Bedford
    Pilgrims House
    Beds
    England
    Director
    Horne Lane
    MK40 1NY Bedford
    Pilgrims House
    Beds
    England
    EnglandBritish154737380001
    HICKS, Anthony Ewen
    Parkfield
    Charlton Road
    GL8 8TS Tetbury
    Gloucestershire
    Director
    Parkfield
    Charlton Road
    GL8 8TS Tetbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritish109577510001
    HUMPHRIES, Anna Clare
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    EnglandBritish258084710001
    IRELAND, Sarah Jane Firman
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    Director
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    United KingdomBritish189708150002
    JOHNSON, Mark Andrew
    35 Waller Road
    Telegraph Hill
    SE14 5LE London
    Director
    35 Waller Road
    Telegraph Hill
    SE14 5LE London
    United KingdomBritish91663210001
    KEELING, David George
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    England
    Director
    Manton Lane
    MK41 7BJ Bedford
    Bedford Heights
    England
    EnglandBritish167603160001
    MANDER, Charles Nicholas, Sir
    Owlpen Manor
    Owlpen
    GL11 5BZ Dursley
    Gloucestershire
    Director
    Owlpen Manor
    Owlpen
    GL11 5BZ Dursley
    Gloucestershire
    EnglandBritish9017150001
    NORMAN, John
    The Paper House
    68 High Street
    SG4 8AL Whitwell
    Hertfordshire
    Director
    The Paper House
    68 High Street
    SG4 8AL Whitwell
    Hertfordshire
    EnglandBritish107082750001
    POTTON, Geoffrey Frederick
    Horne Lane
    MK40 1NY Bedford
    Pilgrims House
    Beds
    England
    Director
    Horne Lane
    MK40 1NY Bedford
    Pilgrims House
    Beds
    England
    United KingdomBritish82324730007
    REED, Nigel George
    Northlands 22 Cotterstock Road
    Oundle
    PE8 5HA Peterborough
    Director
    Northlands 22 Cotterstock Road
    Oundle
    PE8 5HA Peterborough
    United KingdomBritish98838870001
    SPRATLEY, Philippa
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    Director
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    United KingdomBritish200236920001
    STEPHENSON, Ralph Harry, Lt Col
    Lagger Lane
    South Woodchester
    GL5 5EJ Stroud
    Rosare
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Lagger Lane
    South Woodchester
    GL5 5EJ Stroud
    Rosare
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish156742070001
    STOURTON, Nigel John Ivo
    Arbour Hill
    DL8 1JX Patrick Brompton
    North Yorkshire
    Director
    Arbour Hill
    DL8 1JX Patrick Brompton
    North Yorkshire
    British41635360001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Orders Of St John Care Trust
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    06 abr 2016
    Whisby Way
    LN6 3LQ Lincoln
    Eyre Court
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Guarantee
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales Companies House
    Número de registro03073089
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0