THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP
Visión general
| Nombre de la empresa | THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 04667322 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
- Actividades de atención residencial para personas mayores y discapacitadas (87300) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
| Dirección de la sede social | Eyre Court Whisby Way LN6 3LQ Lincoln England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE MILTON KEYNES CARE PARTNERSHIP | 17 feb 2003 | 17 feb 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 28 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 28 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 02 feb 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 16 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 02 feb 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 02 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 25 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Catherine Alice Kelly como director el 01 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Philippa Spratley como director el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 26 páginas | AA | ||
Nombramiento de Miss Hilary Elizabeth Morris como director el 22 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Anthony Stredder como director el 22 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Daniel Hayes el 05 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Mrs Joanna Carole Downing el 05 feb 2024 | 1 páginas | CH03 | ||
Modification des détails de Orders of St Johns Care Trust en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 feb 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 26 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Mark Julian Lee como director el 01 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Kerry Margaret Dearden como director el 31 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Paul Cook como director el 22 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Richard Hill como director el 01 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Kevin Ronald Bolt como director el 30 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Anna Clare Humphries como director el 21 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Anthony Stredder como director el 03 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Mildred Maria Elisabeth Wentworth-Stanley como director el 02 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 26 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Des Roches Square Witney Oxfordshire OX28 4BE England a Eyre Court Whisby Way Lincoln LN6 3LQ el 04 oct 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWNING, Joanna Carole | Secretario | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | 257864410001 | |||||||
| COOK, Paul | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | England | British | 308898950001 | |||||
| HAYES, Daniel | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | United Kingdom | British | 174967940001 | |||||
| HILL, Richard | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | England | British | 158076770002 | |||||
| KELLY, Catherine Alice | Director | Bedford Heights Manton Lane MK41 7BJ Bedford Bpha England | England | British | 290955430001 | |||||
| LEE, Mark Julian | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | England | British | 309710890001 | |||||
| MORRIS, Hilary Elizabeth | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | England | British | 321239160001 | |||||
| PEARCE, Julian Alexander | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | England | British | 275152490001 | |||||
| WARDLE, Tracey | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | United Kingdom | British | 163494080001 | |||||
| FREEMAN, Benjamin Patrick | Secretario | Horne Lane MK40 1NY Bedford Pilgrims House Beds England | 154577370001 | |||||||
| GRAY, Paul | Secretario | Manton Lane MK41 7BJ Bedford Bedford Heights England | 167606590001 | |||||||
| HARTLEY, Michael Jon | Secretario | Kingfishers Green Lane Prestwood HP16 0QA Great Missenden Buckinghamshire | British | 104158540001 | ||||||
| JOHNSON, Mark Andrew | Secretario | 35 Waller Road Telegraph Hill SE14 5LE London | British | 91663210001 | ||||||
| BOLT, Kevin Ronald | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | United Kingdom | British | 127710580001 | |||||
| BOULTER, Janet Elizabeth | Director | Des Roches Square OX28 4BE Witney 1 Oxfordshire England | United Kingdom | British | 100644030003 | |||||
| BURNS, Graham | Director | 138 Offord Road N1 1PF London | United Kingdom | British | 80006320001 | |||||
| CHAMBERS, Antony Craven | Director | The Lake House SO24 9DB Alresford Hampshire | United Kingdom | British | 94516690001 | |||||
| CHEESBROUGH, Andrew | Director | Wellingore Hall Wellingore LN5 0HX Lincoln The Orders Of St John Care Trust England | England | British | 174644360001 | |||||
| CROSS, John William | Director | 34 Church Lane MK44 1HR Sharnbrook Bedfordshire | United Kingdom | British | 49654070004 | |||||
| DEARDEN, Kerry Margaret | Director | Des Roches Square OX28 4BE Witney 1 England | England | British | 212395450001 | |||||
| GOODSON, Frederick Brian, Rear Admiral | Director | Wellingore LN5 0HX Lincoln Wellingore Hall | England | British | 87097210001 | |||||
| GRAY, Paul Lawrence | Director | Manton Lane MK41 7BJ Bedford Bedford Heights England | England | British | 44869860001 | |||||
| GREGORY, Fiona Estelle | Director | Horne Lane MK40 1NY Bedford Pilgrims House Beds England | England | British | 154737380001 | |||||
| HICKS, Anthony Ewen | Director | Parkfield Charlton Road GL8 8TS Tetbury Gloucestershire | United Kingdom | British | 109577510001 | |||||
| HUMPHRIES, Anna Clare | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | England | British | 258084710001 | |||||
| IRELAND, Sarah Jane Firman | Director | Manton Lane MK41 7BJ Bedford Bedford Heights | United Kingdom | British | 189708150002 | |||||
| JOHNSON, Mark Andrew | Director | 35 Waller Road Telegraph Hill SE14 5LE London | United Kingdom | British | 91663210001 | |||||
| KEELING, David George | Director | Manton Lane MK41 7BJ Bedford Bedford Heights England | England | British | 167603160001 | |||||
| MANDER, Charles Nicholas, Sir | Director | Owlpen Manor Owlpen GL11 5BZ Dursley Gloucestershire | England | British | 9017150001 | |||||
| NORMAN, John | Director | The Paper House 68 High Street SG4 8AL Whitwell Hertfordshire | England | British | 107082750001 | |||||
| POTTON, Geoffrey Frederick | Director | Horne Lane MK40 1NY Bedford Pilgrims House Beds England | United Kingdom | British | 82324730007 | |||||
| REED, Nigel George | Director | Northlands 22 Cotterstock Road Oundle PE8 5HA Peterborough | United Kingdom | British | 98838870001 | |||||
| SPRATLEY, Philippa | Director | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | United Kingdom | British | 200236920001 | |||||
| STEPHENSON, Ralph Harry, Lt Col | Director | Lagger Lane South Woodchester GL5 5EJ Stroud Rosare Gloucestershire United Kingdom | England | British | 156742070001 | |||||
| STOURTON, Nigel John Ivo | Director | Arbour Hill DL8 1JX Patrick Brompton North Yorkshire | British | 41635360001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Orders Of St John Care Trust | 06 abr 2016 | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0