RAISEWATER LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAISEWATER LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04717167
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAISEWATER LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RAISEWATER LIMITED?

    Dirección de la sede social
    48a High Street
    HA8 7EQ Edgeware
    Middlesex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAISEWATER LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta05 abr 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para RAISEWATER LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAISEWATER LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    2 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital31 mar 2014

    Estado de capital el 31 mar 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de James Russell como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Lewin como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de First Names Secretaries (Isle of Man) Limited como secretario

    2 páginasTM02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Ifg International (Secretaries) Limited el 01 feb 2013

    3 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 abr 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * 48a High Street Edgware Middlesex HA8 7EQ* el 19 abr 2011

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del secretario Ifg International (Secretaries) Limited el 31 mar 2011

    2 páginasCH04

    Cambio de datos del director James Edmund Russell el 31 mar 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr. Mark Jonathan Lewin el 31 mar 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 05 abr 2010

    6 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Aprirose House 48 High Street Edgware Middlesex HA8 7EQ* el 03 jun 2010

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01

    Cambio de datos del director James Edmund Russell el 03 may 2010

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Ifg International (Secretaries) Limited como secretario

    3 páginasAP04

    Nombramiento de Mark Jonathan Lewin como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de James Edmund Russell como director

    3 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de RAISEWATER LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GUDKA, Manish Mansukhlal
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    Secretario
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    British57254710001
    LEWIN, Mark Jonathan
    Ballacowle Bungalow
    Agneash
    IM4 7NP Lonan
    Isle Of Man
    Secretario
    Ballacowle Bungalow
    Agneash
    IM4 7NP Lonan
    Isle Of Man
    British150917780001
    CHURCH STREET NOMINEES LIMITED
    St George's Court
    Upper Church Street
    IM1 1EE Douglas
    Isle Of Man
    Isle Ofman
    Secretario corporativo
    St George's Court
    Upper Church Street
    IM1 1EE Douglas
    Isle Of Man
    Isle Ofman
    112883660001
    FIRST NAMES SECRETARIES (ISLE OF MAN) LIMITED
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Secretario corporativo
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Forma jurídicaPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalISLE OF MAN
    Número de registro28391C
    203287500001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CAMPBELL, Mary Edel Gabrielle
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Director
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish126356440001
    CAMPBELL, Mary Edel Gabrielle
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Director
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish126356440001
    CARTY, Jane Elicia
    5 Wallberry Mews
    Farmhill
    IM2 2ND Douglas
    Isle Of Man
    Director
    5 Wallberry Mews
    Farmhill
    IM2 2ND Douglas
    Isle Of Man
    British89989340001
    CLAGUE, Steven
    24 Bowness Crescent
    IM3 2DH Onchan
    Isle Of Man
    Director
    24 Bowness Crescent
    IM3 2DH Onchan
    Isle Of Man
    British118858560001
    CORLETT, Mark Richard
    Greenbank
    Bride Road
    IM8 3UN Ramsey
    Isle Of Man
    Director
    Greenbank
    Bride Road
    IM8 3UN Ramsey
    Isle Of Man
    British114060670001
    DENT, Victoria Kim
    35 Ashberry Avenue
    Saddlestone
    IM2 1PY Braddan
    Isle Of Man
    Director
    35 Ashberry Avenue
    Saddlestone
    IM2 1PY Braddan
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish171530280001
    DIVALL, Stuart David
    Ballavitchel Road
    Crosby
    IM4 2DL Isle Of Man
    Borswood
    Director
    Ballavitchel Road
    Crosby
    IM4 2DL Isle Of Man
    Borswood
    Isle Of ManBritish133597360001
    GIBSON, Stuart Marcus
    124 Fairways Drive
    Mount Murray
    IM4 2JB Santon
    Isle Of Man
    Director
    124 Fairways Drive
    Mount Murray
    IM4 2JB Santon
    Isle Of Man
    British116795450001
    GIBSON, Stuart Marcus
    12 Wentworth Close
    Howstrake Heights
    IM3 2JU Onchan
    Isle Of Man
    Director
    12 Wentworth Close
    Howstrake Heights
    IM3 2JU Onchan
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish116794790001
    GUDKA, Manish Mansukhlal
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    Director
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    United KingdomBritish57254710001
    LEWIN, Mark Jonathan
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Director
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish150917780001
    RUSSELL, James Edmund
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Director
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish150562410002
    VENEIK, Vinay
    4 Woodview Close
    Kingston Vale
    SW15 3RL London
    Director
    4 Woodview Close
    Kingston Vale
    SW15 3RL London
    British52547130001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene RAISEWATER LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 10 feb 2006
    Entregado el 28 feb 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 28 feb 2006Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 10 feb 2006
    Entregado el 28 feb 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land k/a land on the east side of dickson road blackpool t/n LA937318. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 28 feb 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 27 jun 2003
    Entregado el 04 jul 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 jul 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 27 jun 2003
    Entregado el 04 jul 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or streamzest limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Leasehold property known as land and buildings on the south side moor house street and land and buildings on the east side of dickson road blackpool lancashire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 jul 2003Registro de un cargo (395)
    Deed of legal charge
    Creado el 15 abr 2003
    Entregado el 30 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from lionsgate properties (no 1) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The l/h land being land and buildings on the east side of dickson road blackpool, on the south side of moor house street blackpool t/n la 465599 and LA470783 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. Fixed charge on all moneys deposited.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transacciones
    • 30 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0