THE TRIBAL GROUP FOUNDATION
Visión general
| Nombre de la empresa | THE TRIBAL GROUP FOUNDATION |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 04730598 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
- Otras actividades de trabajo social sin alojamiento n.c.p. (88990) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Dirección de la sede social | Kings Orchard Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE TRIBAL FOUNDATION | 11 abr 2003 | 11 abr 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Kyle Mcgrath como director el 25 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Martin Cumella como director el 25 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Kyle Mcgrath como director el 25 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Beveridge como director el 25 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Beveridge como director el 25 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 19 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Mark Pickett como director el 18 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Derrick Breach como director el 18 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Keith Martin Evans como director el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2016, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 11 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2015, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Cese del nombramiento de Clive Roderic Ansell como director el 30 jun 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 11 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Stephen Derrick Breach el 05 jun 2014 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ el 04 ago 2014 | 1 páginas | AD01 | ||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2014, aucune liste de membres fournie | 8 páginas | AR01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKETT, Mark Jeremy | Director | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard | England | British | 210493320001 | |||||
| COLLINS, Richard Hawke | Secretario | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | British | 53398040001 | ||||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Secretario | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | 150940560001 | |||||||
| LAWTON, Simon Marcus | Secretario | 28 Henleaze Avenue BS9 4ET Bristol Avon | British | 68807890001 | ||||||
| ALEXANDER, Catherine | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 137531720001 | |||||
| ALI, Lutfur Rahman | Director | 28 Battery Road SE28 0JL London | British | 107803090001 | ||||||
| ANSELL, Clive Roderic | Director | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 297900880001 | |||||
| BENTON, Anthony Henley | Director | The Leys Hoxne IP21 5BP Eye Suffolk | United Kingdom | British | 75082440001 | |||||
| BEVERIDGE, Richard | Director | Barton Road LA1 4ER Lancaster 14 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 129927540001 | |||||
| BREACH, Stephen Derrick | Director | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 174695940001 | |||||
| COLLINS, Helen Victoria | Director | 91a Castlecroft Road Finchfield WV3 8BY Wolverhampton | United Kingdom | British | 85146140002 | |||||
| COLLINS, Richard Hawke | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 53398040001 | |||||
| CORY, Alistair | Director | 142 Divinity Road OX4 1LR Oxford Oxfordshire | British | 82256690001 | ||||||
| CUMELLA, Martin | Director | Wood End Lodge Poolhead Lane, Tamworth In Arden BG4 5ED Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 71794750002 | |||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 155012210001 | |||||
| EVANS, Keith Martin, Dr | Director | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 83582830002 | |||||
| FRAZER, Robert Michael | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Northern Ireland | Northern Irish | 134047440001 | |||||
| GILHEANY, Peter | Director | 27 Harlescott Road SE15 3DA London | United Kingdom | British | 114194370001 | |||||
| GOOD, Martin Edward | Director | 29 Fulbrooke Road CB3 9EE Cambridge | United Kingdom | British | 11362040002 | |||||
| HARRIS, Karen Fiona | Director | 21 Newcombe Park Mill Hill NW7 3QN London Nw7 3qn | British | 58173890001 | ||||||
| KETTLEWELL, Andrew Michael | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Rwanda | British | 155012620001 | |||||
| LAWTON, Simon Marcus | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 68807890001 | |||||
| LUCHMUN, Samatha | Director | Portland Square BS2 8RR Bristol 1-4 United Kingdom | United Kingdom | British | 154378940001 | |||||
| MARTIN, Peter John | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 176044430001 | |||||
| MARTIN, Peter John | Director | Vine Cottage 48 High Street RG10 8BY Wangrove Berkshire | England | British | 176044430001 | |||||
| MCGRATH, Kyle | Director | 23 Millmount Road S8 9EG Sheffield | United Kingdom | British | 114191290001 | |||||
| MIDDLETON, George | Director | High Close House NE41 8BL Wylam . Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 129929830001 | |||||
| NOEL, Elizabeth Mary Alice | Director | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | British | 95923090001 | ||||||
| PITMAN, Henry John | Director | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 55231490005 | |||||
| RICKATSON, Caroline | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Scotland | British | 155008870001 | |||||
| TRICKETT, Christopher | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 150933510001 | |||||
| TRIEU, Nuong | Director | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 154371400001 | |||||
| VISICK, Sarah Jane | Director | 14 Gander Hill RH16 1QX Haywards Heath West Sussex | England | British | 122751160001 | |||||
| WYNNE-JONES, Amy Elizabeth | Director | Portland Square BS2 8RR Bristol 1-4 United Kingdom | United Kingdom | British | 154371180001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribal Group Plc | 01 dic 2016 | Kings Orchard One Queen Street BS2 0HQ Bristol Kings Orchard Bristol United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene THE TRIBAL GROUP FOUNDATION alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creado el 14 jun 2007 Entregado el 21 jun 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0