STRIPEMICRO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTRIPEMICRO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04733405
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STRIPEMICRO LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra STRIPEMICRO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Dfw Associates
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STRIPEMICRO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STRIPEMICRO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    19 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 jun 2019

    24 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 jun 2018

    15 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 jun 2017

    14 páginasLIQ03

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    5 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 16 jun 2016

    LRESEX

    Domicilio social registrado cambiado de Chester Railway Station 1st Floor West Wing Offices Station Road Chester Cheshire CH1 3NT a Dfw Associates 29 Park Square West Leeds West Yorkshire LS1 2PQ el 13 jun 2016

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 14 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 may 2016

    Estado de capital el 25 may 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2015

    Estado de capital el 06 may 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jun 2014

    Estado de capital el 17 jun 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Nombramiento de Theo Michell como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Lovelady como secretario

    2 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de * North House, 17 North John Street, Liverpool Merseyside L2 5EA* el 26 feb 2014

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Andrew Lovelady como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Louise Gail Emery como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Helen Silvano como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Michael Owen como director

    2 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de STRIPEMICRO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EMERY, Louise Gail
    1st Floor West Wing Offices
    Station Road
    CH1 3NT Chester
    Chester Railway Station
    Cheshire
    Secretario
    1st Floor West Wing Offices
    Station Road
    CH1 3NT Chester
    Chester Railway Station
    Cheshire
    British185454520001
    EMERY, Josephine Angela, Dr
    Hibbert Court Birtles Hall
    Birtles Lane
    SK10 4RU Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Hibbert Court Birtles Hall
    Birtles Lane
    SK10 4RU Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish103455000001
    MICHELL, Theodore William Henry
    James Street
    W1U 1EZ London
    46
    United Kingdom
    Director
    James Street
    W1U 1EZ London
    46
    United Kingdom
    United KingdomBritish125430720001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Secretario
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    British41693730006
    SILVANO, Helen
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    Secretario
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    British55343270002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    LAMONT, Neil John Duncan
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    Director
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish90161100001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Director
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish41693730006
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Director
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritish69716360003
    WADSWORTH, David Ian
    Chelwood House
    Malpas Road
    SY14 7HH Tilston
    Cheshire
    Director
    Chelwood House
    Malpas Road
    SY14 7HH Tilston
    Cheshire
    United KingdomBritish47890600002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene STRIPEMICRO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 22 jun 2009
    Entregado el 25 jun 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Parkside 3 herons way chester business park chester. T/no.CH579538 and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 25 jun 2009Registro de un cargo (395)
    Charge on deposit
    Creado el 22 jun 2009
    Entregado el 25 jun 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All monies from time to time standing to the credit of acount number 25812830 (sort code 301474) see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 25 jun 2009Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 26 nov 2008
    Entregado el 28 nov 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land at wrexham road farm chester t/no CH524695 and land at parkside 3 chester t/no CH579538; rental income; floating charge the undertaking and all other property assets and rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ethel Austin Properties Holdings Limited
    Transacciones
    • 28 nov 2008Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 20 dic 2007
    Entregado el 09 ene 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property at wrexham rd,chester. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 09 ene 2008Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 04 oct 2007
    Entregado el 10 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land and buildings k/a 1 hilliards court chester business park chester t/no CH346813 and f/h land and buildings k/a 1B hilliards court chester business park chester and parking spaces t/no CH384901. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 10 oct 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 04 oct 2007
    Entregado el 10 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 10 oct 2007Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene STRIPEMICRO LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    16 jun 2016Inicio de la liquidación
    24 ene 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Frederick Wilson
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    Profesional
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0