FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFRASERS VINCENT SQUARE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04734907
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    • Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FAIRPOINT PROPERTIES (VINCENT SQUARE) LIMITED15 abr 200315 abr 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 15 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 jun 2015

    Estado de capital el 23 jun 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    12 páginasAA

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 15 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 jun 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 jun 2013

    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Valsec Company Secretarial Services Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mr Seng Khoon Ng el 15 abr 2011

    1 páginasCH03

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    legacy

    19 páginasMG01

    Nombramiento de Valsec Company Secretarial Services Limited como secretario

    3 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Valad Secretarial Services Limited como secretario

    2 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NG, Seng Khoon
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Secretario
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    British90211410001
    CHIA, Khong Shoong
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    Director
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    SingaporeSingaporean141112510002
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Director
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Director
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Secretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    MCS FORMATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Secretario corporativo
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69736830002
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Secretario corporativo
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Secretario corporativo
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro7307485
    154204150001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Director
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Director
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    CHEONG, Anthony Fook Seng
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Director
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Malaysian77121980001
    DODWELL, John Christopher
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    Director
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    United KingdomBritish95741610002
    HENG, Jeffrey Wah Yong
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Director
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Singaporean70088270001
    LEAR, Simon John Patrick
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    Director
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    United KingdomBritish107485520001
    LIM, Ee Seng
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    Director
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    SingaporeanSingaporean123920850001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Director
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    EnglandBritish90211410001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Director
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    MCS INCORPORATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Director corporativo
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69737020001

    ¿Tiene FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 dic 2010
    Entregado el 31 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company each obligor investor or the investors' guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 31 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 19 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment
    Creado el 19 jul 2006
    Entregado el 22 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The entire right title and interest in and to the specific contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 may 2003
    Entregado el 10 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property situate at 63-69 (odd) rochester row and 68 vincent square london SW1 title number NGL785625. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 may 2003
    Entregado el 10 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0