ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED

ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASHBOURNE HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04743237
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 31 ago 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Charles Lovett como director el 31 ago 2012

    2 páginasAP01

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    4 páginas1.1

    Déclaration annuelle établie au 24 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 abr 2012

    Estado de capital el 25 abr 2012

    • Capital: GBP 3
    SH01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Director
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304760001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Director
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Director
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Director
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Director
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Director
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Director
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Director
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Director
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Director
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Director designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    ¿Tiene ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 29 feb 2008
    Entregado el 14 mar 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 14 mar 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 06 jun 2007
    Entregado el 19 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 19 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 jul 2006
    Entregado el 20 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 20 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession and charge
    Creado el 02 dic 2005
    Entregado el 15 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 15 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 01 abr 2005
    Entregado el 19 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever or all monies due or to become due from cannon capital ventures limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transacciones
    • 19 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 10 feb 2005
    Entregado el 24 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and cannon capital ventures limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property now owned by it, and all buildings and fixtures and fixed plant and fixed machinery, all of its book and other debts, any know-how, patent, trade mark, service mark, design, business name, any copyright or other intellectual property monopoly right. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors(The Security Agent)
    Transacciones
    • 24 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Shares charge
    Creado el 17 jun 2003
    Entregado el 24 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fortis Bank S.A./ N.V.
    Transacciones
    • 24 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 jun 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    20 ago 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0