OLDVINE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OLDVINE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04750376 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OLDVINE LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra OLDVINE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 4 Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells Kent |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OLDVINE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DUNWILCO (1055) LIMITED | 01 may 2003 | 01 may 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OLDVINE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OLDVINE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 14 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 abr 2018 | 13 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 abr 2017 | 12 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 abr 2016 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 33 18th Floor Cavendish Square London W1G 0PW a 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE el 07 may 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2015 | AA | |||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 21 nov 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephane Abraham Joseph Nahum como director el 01 may 2014 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Robin Turner como director el 01 may 2014 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Cairns Mcmahon como director el 01 may 2014 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 13 nov 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OLDVINE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOFI, Christakis, Mr. | Secretario | 10 Litchfield Way NW11 6NJ London | British | 67125820002 | ||||||
| MCCABE, Gary John | Director | Cleuch Avenue North Middleton EH23 4RP Gorebridge 6 Midlothian | Scotland | British | 139525550001 | |||||
| SCOTT, Keith | Secretario | Clarendon Road HP16 0PL Prestwood Michaelmas Farm Buckinghamshire | British | 141163370001 | ||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
| ANDERSON, Bruce Smith | Director | 2 Bramdean View EH10 6JX Edinburgh | Scotland | British | 73849040001 | |||||
| BAKER, David Leon | Director | 14 Nottingham Terrace Regents Park NW1 4QB London | England | British | 46822620002 | |||||
| HEWITT, Alistair James Neil | Director | 12 Annickbank Stewarton KA3 5QT Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 113081830001 | |||||
| KASCH, Peter Carwile | Director | Filston Oast Filston Lane TN14 5JU Shoreham Kent | United Kingdom | British | 61386600003 | |||||
| KERR, Donald | Director | 28 Burnbank EH20 9NE Straiton Midlothian | British | 84247450001 | ||||||
| MACKINTOSH, Iain Stewart | Director | 9 Greenbank Terrace EH10 6ER Edinburgh Midlothian | British | 94163020001 | ||||||
| MCMAHON, James Cairns | Director | Greenacres Kerrix Road KA1 5QP Symington Ayrshire | Scotland | British | 159708270001 | |||||
| NAHUM, Stephane Abraham Joseph | Director | 21a Kensington High Street W8 5NP London | England | French | 99292580003 | |||||
| SELLAR, Gillian Christine | Director | 112 Seaview Terrace EH15 2HQ Edinburgh Midlothian | British | 107180940001 | ||||||
| TRIBE, Nicholas John Grove | Director | Yew Tree Cottage Sherbourne Street, Edwardstone CO10 5PD Sudbury Suffolk | United Kingdom | British | 141163390001 | |||||
| TURNER, Malcolm Robin | Director | 18 Jay Mews SW7 2EP London | United Kingdom | British | 60293070001 | |||||
| D.W. DIRECTOR 1 LIMITED | Director designado corporativo | 4th Floor Saltire Court, 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900021330001 | |||||||
| D.W. DIRECTOR 2 LIMITED | Director designado corporativo | 4th Floor Saltire Court, 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900021320001 |
¿Tiene OLDVINE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 04 mar 2004 Entregado el 19 mar 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of a first floating charge the whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the charge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 jul 2003 Entregado el 02 ago 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene OLDVINE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0