STAMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTAMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04783263
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STAMS LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra STAMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Interpath Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STAMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ST ANDREW'S MEMBERSHIP SERVICES LTD02 jun 200302 jun 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STAMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STAMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    17 páginasLIQ13

    Cese del nombramiento de Claude Kwasi Sarfo-Agyare como director el 20 dic 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 20 sept 2022

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN United Kingdom a C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 04 oct 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    17 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare el 07 sept 2020

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare como director el 04 nov 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew James Morris como director el 04 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Andrew James Morris el 04 ene 2019

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de Timothy Patrick Clancy como director el 31 jul 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Lifestyle Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 may 2018

    2 páginasPSC05

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN

    1 páginasAD04

    Domicilio social registrado cambiado de 6-12 Victoria Street Windsor Berkshire SL4 1EN a Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN el 29 may 2018

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Darren John Billings como director el 07 dic 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de STAMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PADDOCK, Natalie Ann
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    192663430001
    BUTLER, John Michael
    27 Headingley Mews
    St John's
    WF1 3AB Wakefield
    West Yorkshire
    Secretario
    27 Headingley Mews
    St John's
    WF1 3AB Wakefield
    West Yorkshire
    British87985410004
    GRAVES, John Osborne
    Little Paddock
    3 White Beam Way
    KT20 5DL Tadworth
    Surrey
    Secretario
    Little Paddock
    3 White Beam Way
    KT20 5DL Tadworth
    Surrey
    English51918630002
    GRAVILLE, Christian
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    British182767970001
    LLOYD, Steven
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Secretario
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    British133212170002
    BALSLEY, William Michael
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomAmerican161064690001
    BILLINGS, Darren John
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish103631680002
    BLACK, Ian Spencer
    402 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    402 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish50474580001
    BLUNDELL, John Giles
    1 Littlewick Place
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    Director
    1 Littlewick Place
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish40752730002
    CLANCY, Timothy Patrick
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish250013690001
    DEVEY, Robert Alan
    16 Langcliffe Avenue
    HG2 8JQ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    16 Langcliffe Avenue
    HG2 8JQ Harrogate
    North Yorkshire
    UkBritish101508990001
    DOBSON, Philip David
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Director
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United KingdomBritish95437530004
    KIRKWOOD, Alan Ford
    5 Craiglockhart Loan
    EH14 1HU Edinburgh
    Midlothian
    Director
    5 Craiglockhart Loan
    EH14 1HU Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish116266980001
    MORRIS, Andrew James
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish188465670001
    MORRIS, John Edward
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Director
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    EnglandBritish92903390003
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Director
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritish139631580001
    PRINGLE, Martin John
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish278248950001
    SARFO-AGYARE, Claude Kwasi
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170061790002
    VIALOU CLARK, Henry Max
    66 Cornwall Road
    HG1 2NE Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    66 Cornwall Road
    HG1 2NE Harrogate
    North Yorkshire
    British108160470001
    WARREN, Michael Ian
    137 Oakenshaw Lane
    Walton
    WF2 6NL Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    137 Oakenshaw Lane
    Walton
    WF2 6NL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish94336310002
    WHITEHAIR, Colin Roy Keith
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Director
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    EnglandBritish3042720002
    WHITING, Timothy James
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Director
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United KingdomBritish44028500003
    WOOLGROVE, Thomas
    Northwold
    Woodacre Crescent Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Northwold
    Woodacre Crescent Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British103184580001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STAMS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05114385
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene STAMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 15 may 2013
    Entregado el 24 may 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 may 2013Registro de una carga (MR01)
    • 14 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus set-off agreement
    Creado el 22 dic 2011
    Entregado el 23 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 14 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 may 2011
    Entregado el 16 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V.London Branch (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 16 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 14 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Creado el 12 feb 2010
    Entregado el 16 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 24 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Consent letter
    Creado el 08 dic 2009
    Entregado el 18 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The short particulars of all the property mortgaged or charged are as set out in the debenture, in the consent letter the company charges, all investments, including any dividend, see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transacciones
    • 18 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 24 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Omnibus letter of set-off (oslo)
    Creado el 24 sept 2009
    Entregado el 01 oct 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 oct 2009Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    A deed of accession
    Creado el 29 jun 2009
    Entregado el 07 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V, London Branch (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 07 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene STAMS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 sept 2022Inicio de la liquidación
    15 ago 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    Interpath Limited 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    Interpath Limited 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0