MCV EDGBASTON LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMCV EDGBASTON LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04815435
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MCV EDGBASTON LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra MCV EDGBASTON LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Level 13 The Broadgate Tower
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MCV EDGBASTON LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOUTHMORE LIMITED30 jun 200330 jun 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MCV EDGBASTON LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MCV EDGBASTON LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Domicilio social registrado cambiado de Royal London House 22-25 Finsbury Square London EC2A 1DX el 18 ene 2011

    2 páginasAD01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 ago 2010

    Estado de capital el 24 ago 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Domicilio social registrado cambiado de 58 Davies Street 1st Floor London W1K 5JF el 20 jul 2010

    1 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Kennedy como director

    2 páginasTM01

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    13 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    12 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    12 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    3 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de MCV EDGBASTON LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Director
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritishSurveyor59050120004
    PORTER, Barry
    22 Dove Park
    WD3 5NY Chorleywood
    Hertfordshire
    Director
    22 Dove Park
    WD3 5NY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBanker99637030001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BLAKEMORE, James Corry
    42 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Director
    42 Clarendon Road
    W11 3AD London
    AmericanBanker86416170001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    Director
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritishBanker76547250001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Director
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Surveyors71043680001
    KILLICK, William James
    Flat 3
    79 Church Road
    TW10 6LX Richmond
    Surrey
    Director
    Flat 3
    79 Church Road
    TW10 6LX Richmond
    Surrey
    BritishInvestment Banker71352980001
    LAWRIE, Ronald Rozmus
    New Providence Wharf A501
    1 Fairmont Avenue
    E14 9PA London
    Director
    New Providence Wharf A501
    1 Fairmont Avenue
    E14 9PA London
    AmericanBanker96955160001
    PETTIT, Andrew John
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    Director
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    BritishInvestment Banker62947400001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Director designado corporativo
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    ¿Tiene MCV EDGBASTON LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 10 dic 2004
    Entregado el 23 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each borrower to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property being edgebaston house (3 duchess place) and the car park at 30-36 duchess road edgebaston birmingham, all fittings plant equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 23 dic 2004Registro de un cargo (395)
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 22 august 2003
    Creado el 10 dic 2004
    Entregado el 17 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H properties k/a edgbaston house, 3 duchess place, edgbaston, birmingham and 30-36 duchess place, edgbaston, birmingham, right title and interst in all agreements, contracts, deeds, licences, rent and disposal proceeds and insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mable Commercial Funding Limited (The Agent)
    Transacciones
    • 17 dic 2004Registro de un cargo (395)
    Supplemental debenture
    Creado el 10 mar 2004
    Entregado el 11 mar 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property 1 duchess place edgbaston birmingham. L/h property 2 duchess place edgbaston birmingham. L/h property regency house 97-107 hagley road edgbaston birmingham. The benefit of all of its right title and interest to in and under all agreements contracts deed licences undertakings guarantees covenants warranties representations and other documents. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mable Commercial Funding Limited (The Agent)
    Transacciones
    • 11 mar 2004Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 03 feb 2004
    Entregado el 21 feb 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each borrower to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property 1 duchess place edgbaston birmingham, l/h property 2 duchess place edgbaston birmingham, l/h property regency house 97-107 hagley road edgbaston birmingham any f/h or l/h property acquired, by way of fixed charge all existing and future fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transacciones
    • 21 feb 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 22 ago 2003
    Entregado el 23 ago 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transacciones
    • 23 ago 2003Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 22 ago 2003
    Entregado el 23 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the borrower to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The l/h property k/a 1,2&3 duchess place edgbaston birmingham t/n WK176682 WK186385 WM13776 (for further details of the property charged please refer to the form 395) together with all fittings plant machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property, any money standing to the credit of any account, insurances court order and any debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transacciones
    • 23 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture and floating charge
    Creado el 22 ago 2003
    Entregado el 22 ago 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors (or by some other person) to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property 1 duchess place, hagley road, birmingham t/n WK176682, l/h property 2 duchess place, duchess road, edgbaston, birmingham t/n WK186385, l/h property 3 duchess place, edgbaston house, birmingham t/n WM13776 for details of further property charged please refer to form 395. the relevant shares and all its other present and future shares in any subsidiary of the parent. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mable Commercial Funding Limited (The Agent)
    Transacciones
    • 22 ago 2003Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0