OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04824858 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 sept 2018 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 sept 2017 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Place Ducie Street Manchester M1 2TP a 15 Canada Square London E14 5GL el 20 oct 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notificación de finalización del acuerdo voluntario | 47 páginas | 1.4 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard James Spencer como director el 04 jun 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Brett Alan Lashley como director el 04 jun 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Brett Alan Lashley como director el 25 feb 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Craig Allan Mellor como director el 25 feb 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gavin Robert Duncan como director el 25 feb 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Criag Allan Mellor como secretario el 25 feb 2015 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart Barrie Wall como director el 25 feb 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a The Place Ducie Street Manchester M1 2TP el 06 mar 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Aviso de finalización de la administración | 74 páginas | 2.32B | ||||||||||
Informe de progreso del administrador hasta 10 ene 2015 | 67 páginas | 2.24B | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor | 9 páginas | 1.1 | ||||||||||
Aviso de extensión del período de la administración | 1 páginas | 2.31B | ||||||||||
Informe de progreso del administrador hasta 10 jul 2014 | 90 páginas | 2.24B | ||||||||||
Informe de progreso del administrador hasta 10 ene 2014 | 65 páginas | 2.24B | ||||||||||
Aviso de extensión del período de la administración | 1 páginas | 2.31B | ||||||||||
Informe de progreso del administrador hasta 17 sept 2013 | 77 páginas | 2.24B | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER, Richard James | Director | Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court 133 London United Kingdom | United Kingdom | British | 190526870001 | |||||
| DRAPER, Abigail Sarah | Secretario | 265 Chester Road, Helsby WA6 0PN Frodsham Cheshire | British | 107928180001 | ||||||
| HARRISON, Irene Lesley | Secretario designado | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||
| MELLOR, Criag Allan | Secretario | 21 Queenston Road M20 2NX Manchester Lancashire | British | 100890520001 | ||||||
| DUNCAN, Gavin Robert | Director | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | 151512820001 | |||||
| LASHLEY, Brett Alan | Director | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | United States Of America | 196201790001 | |||||
| MARTIN, Graham Hunter | Director | Rosegarth 51 Adlington Road SK9 2BJ Wilmslow Cheshire | British | 87259480001 | ||||||
| MELLOR, Craig Allan | Director | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | 60906780002 | |||||
| SMITH, David Ryder | Director | 5 Acacia Avenue WA15 8QX Hale Cheshire | England | British | 202067380001 | |||||
| WALL, Stuart Barrie | Director | Old Acres Well Bank Lane Over Peover WA16 8UN Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 95010340001 | |||||
| BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED | Director designado corporativo | Crown House 64 Whitchurch Road CF14 3LX Cardiff | 900005500001 |
¿Tiene OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Creado el 04 abr 2012 Entregado el 19 abr 2012 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 07 may 2004 Entregado el 11 may 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h land and buildings k/a condor works located on the north side of rusholme place, manchester t/n LA187336, by way of assignment the gross rents licence fees and other monies; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 26 sept 2003 Entregado el 10 oct 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of first legal mortgage the f/h property k/a wilmslow park wilmslow road manchester t/no GM683090 and opal court de montfort street leicester t/no LT27667 and including all rights and buildings fixtures fittings plant and machinery, the gross rents licence fees and other monies receivable, the benefit of all guarantees and all and any agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 sept 2003 Entregado el 25 sept 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 12 sept 2003 Entregado el 25 sept 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN362302, the f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN233238, the f/h property k/a phoenix house notte street plymouth and t/n DN303418. The gross rent licence fees and other monies , the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements relating to the property and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| En administración |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 4 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0