OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOPAL PORTFOLIO 3 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04824858
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 sept 2018

    7 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 sept 2017

    7 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de The Place Ducie Street Manchester M1 2TP a 15 Canada Square London E14 5GL el 20 oct 2016

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 sept 2016

    LRESSP

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    47 páginas1.4

    Nombramiento de Mr Richard James Spencer como director el 04 jun 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Brett Alan Lashley como director el 04 jun 2015

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Brett Alan Lashley como director el 25 feb 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Craig Allan Mellor como director el 25 feb 2015

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gavin Robert Duncan como director el 25 feb 2015

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Criag Allan Mellor como secretario el 25 feb 2015

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Stuart Barrie Wall como director el 25 feb 2015

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a The Place Ducie Street Manchester M1 2TP el 06 mar 2015

    2 páginasAD01

    Aviso de finalización de la administración

    74 páginas2.32B

    Informe de progreso del administrador hasta 10 ene 2015

    67 páginas2.24B

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    9 páginas1.1

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 10 jul 2014

    90 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 10 ene 2014

    65 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 17 sept 2013

    77 páginas2.24B

    ¿Quiénes son los directivos de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SPENCER, Richard James
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    Director
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    DRAPER, Abigail Sarah
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    Secretario
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    British107928180001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secretario designado
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MELLOR, Criag Allan
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    Secretario
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    British100890520001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Director
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Director
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Director
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Director
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Director
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Director designado corporativo
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    ¿Tiene OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Group debenture
    Creado el 04 abr 2012
    Entregado el 19 abr 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transacciones
    • 19 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    Legal charge
    Creado el 07 may 2004
    Entregado el 11 may 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h land and buildings k/a condor works located on the north side of rusholme place, manchester t/n LA187336, by way of assignment the gross rents licence fees and other monies; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transacciones
    • 11 may 2004Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 26 sept 2003
    Entregado el 10 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage the f/h property k/a wilmslow park wilmslow road manchester t/no GM683090 and opal court de montfort street leicester t/no LT27667 and including all rights and buildings fixtures fittings plant and machinery, the gross rents licence fees and other monies receivable, the benefit of all guarantees and all and any agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 10 oct 2003Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 sept 2003
    Entregado el 25 sept 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 25 sept 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 12 sept 2003
    Entregado el 25 sept 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN362302, the f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN233238, the f/h property k/a phoenix house notte street plymouth and t/n DN303418. The gross rent licence fees and other monies , the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements relating to the property and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 25 sept 2003Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 mar 2013Inicio de la administración
    20 feb 2015Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    FechaTipo
    12 dic 2014Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    22 oct 2015Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    FechaTipo
    30 sept 2016Inicio de la liquidación
    22 ago 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0