THINC ENTITIES LIMITED

THINC ENTITIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHINC ENTITIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04836733
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THINC ENTITIES LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra THINC ENTITIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THINC ENTITIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THINC GROUP LIMITED17 jul 200317 jul 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THINC ENTITIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para THINC ENTITIES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THINC ENTITIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 may 2014

    Estado de capital el 15 may 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nombramiento de David Richard Cheeseman como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Graham Harvey como director

    1 páginasTM01

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    3 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    3 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Estado de capital el 27 dic 2012

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account and miscellaneous reserve balance 27/12/2012
    RES13

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Nombramiento de Christopher Graham Bobby como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip Anderson como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Graham Harvey como director

    3 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Jeremy Peter Small el 23 abr 2010

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de THINC ENTITIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    British67168210001
    BOBBY, Christopher Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish170592990001
    CHEESEMAN, David Richard
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritish132416500001
    HARKIN, Neil Michael
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    Secretario
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    British146701610001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Secretario
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    British130449650001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ANDERSON, Philip John
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    UkBritish79136250001
    BALDWIN, Keith Reginald
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish7401430002
    BAYLISS, Keith Ronald
    3 Chesterford House
    28 Store Street
    WC1E 7BS London
    Director
    3 Chesterford House
    28 Store Street
    WC1E 7BS London
    British55337400002
    BOYLE, Nicholas
    2 Mount Pleasant
    Stanmills
    BT9 5DS Belfast
    County Antrim
    Director
    2 Mount Pleasant
    Stanmills
    BT9 5DS Belfast
    County Antrim
    British141649010001
    CHAMBERLAIN, Simon John
    Manor Cottage
    Crackington Haven
    EX23 0JG Bude
    Cornwall
    Director
    Manor Cottage
    Crackington Haven
    EX23 0JG Bude
    Cornwall
    EnglandBritish133883740012
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    Director
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    British105488120003
    HARKIN, Neil Michael
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    Director
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish146701610001
    HARRAGAN, Stephen William
    36 Birch Lane
    CM4 9NA Stock
    Essex
    Director
    36 Birch Lane
    CM4 9NA Stock
    Essex
    United KingdomBritish16510590003
    HARVEY, Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish168974600001
    PIERCE, Raymond Francis
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    Director
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish3231870001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Director
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritish130449650001
    TAYLOR, Gregg
    Meadowvale
    Wellington Hill, High Beach
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    Director
    Meadowvale
    Wellington Hill, High Beach
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    United KingdomBritish93705800003
    TROTTER, Timothy Hugh Southcombe
    Field Burcote House
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    Director
    Field Burcote House
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish86031170001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Tiene THINC ENTITIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over shares
    Creado el 25 nov 2005
    Entregado el 10 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Right, title and interest in and to the shares and any securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 25 nov 2005
    Entregado el 08 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of second fixed charge its entire right title and interest in and to the shares and to any securities and all dividends monies and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential UK Services Limited
    Transacciones
    • 08 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 nov 2005
    Entregado el 08 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property k/a the guard house, fulford road, york, level 2 vitners place, 68 upper thames street, london, park house west, heatcote road, camberley t/no SY741619 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential UK Services Limited
    Transacciones
    • 08 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 21 oct 2004
    Entregado el 26 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £10,674.
    Personas con derecho
    • The Trustees of the National Heritage Memorial Fund
    Transacciones
    • 26 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of debts by way of security
    Creado el 05 oct 2004
    Entregado el 21 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or thinc finance limited to the charge on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the future rights, titles and interests in and benefits of the company whatsoever in the debts, together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creado el 05 oct 2004
    Entregado el 21 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All sums (denominated in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the bank account of the company with bos. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 may 2004
    Entregado el 21 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 feb 2004
    Entregado el 26 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0