RMAC 2003-NS4 PLC
Visión general
Nombre de la empresa | RMAC 2003-NS4 PLC |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
Número de empresa | 04842501 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RMAC 2003-NS4 PLC?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra RMAC 2003-NS4 PLC?
Dirección de la sede social | 40a Station Road RM14 2TR Upminster Essex |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RMAC 2003-NS4 PLC?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RMAC 2003-NS4 PLC?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Arlington Square Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1WA a 40a Station Road Upminster Essex RM14 2TR el 09 nov 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Atkin como secretario el 12 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Nicola Townsend como secretario el 12 sept 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2017 au 30 dic 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vinoy Rajanah Nursiah como director el 13 oct 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Paivi Helena Whitaker como director el 13 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Sfm Directors Limited el 09 dic 2016 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Sfm Directors (No.2) Limited el 09 dic 2016 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Qui énes son los directivos de RMAC 2003-NS4 PLC?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWNSEND, Nicola | Secretario | Station Road RM14 2TR Upminster 40a Essex | 250432680001 | |||||||||||
WHITAKER, Helena Paivi | Director | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England | United Kingdom | Finnish | Company Director | 163184240010 | ||||||||
INTERTRUST DIRECTORS 1 LIMITED | Director corporativo | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 |
| 69353890003 | ||||||||||
INTERTRUST DIRECTORS 2 LIMITED | Director corporativo | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 |
| 71663610004 | ||||||||||
ATKIN, Dean | Secretario | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | 154554890001 | |||||||||||
EDMONDS, Karen Britt | Secretario | Badgers Barn Farthings Paddock BA7 7QA Alford Somerset | British | 42484650004 | ||||||||||
SIMPSON, Phillip Bertram | Secretario | 16 Gatscombe Crescent Hanover Park SL5 7HA Ascot | British | Solicitor | 54705580002 | |||||||||
ACHESON, William Brian | Director | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | American | Director | 100315920003 | |||||||||
BRADLEY, Colin Walter | Director | Williamsgate The Street RG27 0PJ Eversley Hampshire | British | Director Of Finance | 70001440003 | |||||||||
HIGGINS, Christopher James | Director | 24 Ennismore Avenue GU1 1SR Guildford Surrey | British | Finance Director | 115417740001 | |||||||||
LUNDGREN, Jefrey Andrew | Director | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130391340002 | ||||||||
NURSIAH, Vinoy Rajanah | Director | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | United Kingdom | British | Director Of Client Accounting & Finance | 165402030001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RMAC 2003-NS4 PLC?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmac Holdings Limited | 06 abr 2016 | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene RMAC 2003-NS4 PLC alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Assignation in security | Creado el 07 mar 2007 Entregado el 15 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the order of the chargee and/or receiver, ambac and to each of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The whole right title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Assignation in security | Creado el 28 nov 2006 Entregado el 05 dic 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or receiver and to ambac under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The company's whole right, title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Assignation in security | Creado el 03 jul 2006 Entregado el 08 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or receiver, ambac assurance UK limited and to each of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The right title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of amendment | Creado el 30 sept 2005 Entregado el 17 oct 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the trustee and/or any receiver and to ambac and to each of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed security with full title guarantee all right title interest and benefit in the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and the title deeds and documents relating to the property in england and wales. All right title and interest in the scottish trust property, the charged obligation documents, floating charge all undertaking property and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Assignation in security | Creado el 28 ene 2004 Entregado el 06 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the trustee and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The company's whole right, title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge and assignment | Creado el 03 dic 2003 Entregado el 11 dic 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver and each of the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed equitable charge all the company's right title interest and benefit in and to and under the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and all monies assured by or to become payable under the same and the benefit of all covenants relating thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene RMAC 2003-NS4 PLC algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0