PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED

PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPREFERRED FUNDING FIVE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04930708
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hays Galleria
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PINKCLOSE LIMITED14 oct 200314 oct 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2018

    7 páginasLIQ03

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 sept 2017

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Declaración de confirmación presentada el 27 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 10-18 Union Street London SE1 1SZ United Kingdom a Hays Galleria 1 Hays Lane London SE1 2rd el 13 abr 2017

    2 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    6 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    6 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2015

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2016

    Estado de capital el 15 jun 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Level 23 25 Canada Square London E14 5LQ a 10-18 Union Street London SE1 1SZ el 22 ene 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2014

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2015

    Estado de capital el 15 jun 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2013

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 jun 2014

    Estado de capital el 03 jun 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2012

    16 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Other company business 08/03/2013
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2011

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRANDON, Lee Christopher
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    Director
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United KingdomBritish152212570001
    HOPES, Philip Edward
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    Secretario
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    British59370220003
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    Secretario corporativo
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    83911920002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor, 9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Secretario corporativo
    1st Floor, 9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06902863
    140723560001
    ATTIA, Amany
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    Director
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    United KingdomFrench - American94699620002
    ATTIA, Amany
    The Old House
    W6 7BD 101 Brook Green
    London
    Director
    The Old House
    W6 7BD 101 Brook Green
    London
    French American94699620001
    BILSBOROUGH, William C
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Director
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Us Citizen107220450001
    CHAMBERS, Paul Stuart
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    Director
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    United KingdomBritish172496620001
    FRASER, George Mclennan
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    Director
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    Australian94699810001
    GIBB, Dominic Iain
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    Director
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    British62250460004
    HINSHELWOOD, Wallace Simon Duthie
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish91642420002
    HOPES, Philip Edward
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    Director
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    British59370220003
    INGRAM, Nigel Jeffrey Martin
    Meadowlands
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    Director
    Meadowlands
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish97379760001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Director designado
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MEHR, Amir
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    Director
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    United KingdomAmerican130034860001
    PATELLIS, George
    The Gatehouse
    20 Kings Gate
    RH16 1DY Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    The Gatehouse
    20 Kings Gate
    RH16 1DY Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomAmerican76275030002
    PITOCCO, Dennis James
    The Annexe Cedar Lodge
    6 Calbourne
    RH16 4AQ Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    The Annexe Cedar Lodge
    6 Calbourne
    RH16 4AQ Haywards Heath
    West Sussex
    American59515170003
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Director
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritish162620820001
    RUPP, Christopher Gordon
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    Director
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish72545640001
    STAID, Stephen
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    Director
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomAmerican125380160001
    TAYLOR, Roger John
    Rare Oak
    Highfield Gardens
    GU33 7NQ Liss
    Hampshire
    Director
    Rare Oak
    Highfield Gardens
    GU33 7NQ Liss
    Hampshire
    British68131560002
    WEIR, Louise Jane
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    Director
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    EnglandBritish130033570001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United Kingdom
    06 abr 2016
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUk
    Autoridad legalUnited Kingdom (Uk)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03137809
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A warehouse deed of charge
    Creado el 09 nov 2005
    Entregado el 28 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affilliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title interest and benefit present and future in the secur ity assets the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Storm Funding Limited
    Transacciones
    • 28 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 30 may 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 may 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    An amended and restated deed relating to a warehouse deed of charge dated 27 july 2005 and
    Creado el 09 nov 2005
    Entregado el 23 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title interest and benefit, present and future, in the security assets, the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Storm Funding Limited (Holding the Benefit of the Security on Trust for the Secured Parties,Including Itself)
    Transacciones
    • 23 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignation in security
    Creado el 25 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company's whole right title and interest in and to the scottish mortgage trust property and in and to the scottish declaration of trust.
    Personas con derecho
    • Storm Funding Limited Acting as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A warehouse deed of charge
    Creado el 25 oct 2005
    Entregado el 26 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right, title, interest and benefit, present and future in the security assets the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Storm Funding Limited Acting as Security Truatee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 26 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 16 ene 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 06 ago 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 31 ene 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 31 ene 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 may 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 may 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental assignation in security
    Creado el 28 jul 2005
    Entregado el 17 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any of all of the secured parties or to any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All principal sums and further advances all of scotish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Storm Funding Limited (The Secutrity Trustee)
    Transacciones
    • 17 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A warehouse deed of charge
    Creado el 27 jul 2005
    Entregado el 16 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in the security assets including the english mortgage loans and northern irish mortgage loans, the right to demand sue for recover receive and give receipts for all principal moneys payable or to become payable under the english mortgage loans or the northern irish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Storm Funding Limited (Holding the Benefit of the Security on Trust for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 16 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 ene 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 ene 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 may 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 may 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignation in security
    Creado el 18 nov 2003
    Entregado el 03 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or preferred mortgages limited to any or all of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The whole right, title and interest, present and future, in and to the scottish mortgage trust property and in and to the scottish declaration of trust.
    Personas con derecho
    • Mable Commercial Funding Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transacciones
    • 03 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Warehouse deed of charge
    Creado el 05 nov 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in the security assets including the english mortgage loans and northern irish mortgage loans, the right to demand sue for recover receive and give receipts for all principal moneys payable or to become payable under the english mortgage loans or the northern irish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mable Commercial Funding Limited as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 sept 2017Inicio de la liquidación
    08 feb 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0