SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04939129 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED?
- Establecimientos residenciales de cuidados de enfermería (87100) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED?
Dirección de la sede social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
EVER 2220 LIMITED | 21 oct 2003 | 21 oct 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 15 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2019 | 31 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Reynolds Skiver el 10 oct 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 20 abr 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 8 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Justin Reynolds Skiver como director el 01 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Anthony Goodey como director el 01 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2016 au 30 jun 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Bedell Trust Uk Limited el 15 nov 2016 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 oct 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Keith Russell Crockett como director el 30 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Anthony Goodey como director el 01 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Caroline Mary Roberts como director el 01 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Skiver como director el 01 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Erin Carol Ibele como director el 01 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Nabarro Llp 1 South Quay Wharf Street Sheffield South Yorkshire S2 5SY England a C/O Bedell Trust Uk Limited 11 Old Jewry London EC2R 8DU | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCORIAN (UK) LIMITED | Secretario corporativo | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England |
| 113583560003 | ||||||||||
ROBERTS, Caroline Mary | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | American | Company Director | 206974150001 | ||||||||
SKIVER, Justin Reynolds | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | American | Director | 241791140003 | ||||||||
GORDON, Iain | Secretario | The Ridgeway SL7 3LQ Marlow 9 Buckinghamshire United Kingdom | British | 135187090001 | ||||||||||
MILLIKEN, Alistair | Secretario | 34 Elwill Way BR3 3AD Beckenham Kent | British | 74424700001 | ||||||||||
EPS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | London Wall EC2Y 5AL London 125 United Kingdom |
| 67339580001 | ||||||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Secretario designado corporativo | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||||||
STATE STREET SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Churchill Place Canary Wharf E14 5HJ London 20 United Kingdom |
| 108845150006 | ||||||||||
ADAMS, Carl George | Director | 4746 Holly Ave IRISH Fairfax Virginia 22030 Usa | American | Director | 123180810001 | |||||||||
BARGERON, Ann | Director | 75 Fourteenth Street 23rd Floor Atlanta Ga 30309 Usa | Usa | American | Consultant | 163123490001 | ||||||||
CRABTREE, Michael Andrew | Director | House 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon United Kingdom | Usa | Us Citizen | Senior Vice President & Treasurer | 175436800001 | ||||||||
CROCKETT, Keith Russell | Director | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England | United Kingdom | British | Vice President, Uk Investments, Health Care Reit | 179532870001 | ||||||||
DRYDEN, Rachel | Director | Elmthorpe Road Wolvercote OX2 8PA Oxford 42 | England | British | Director | 137848010005 | ||||||||
FRANTZ, Edward A | Director | Silver Spring 13422 Rippling Brook Drive 20906 Maryland | Usa | United States | Vp & Assoc Gen Counsel | 135784330001 | ||||||||
GELLER, Guy | Director | Warwick Road HP9 2PE Beaconsfield 16 Buckinghamshire | Usa Illinois | British | Svp Of Operations | 163224790001 | ||||||||
GOODEY, John Anthony | Director | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor | England | British | Company Director | 207171280001 | ||||||||
IBELE, Erin Carol | Director | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England | Usa | American | Senior Vice President Admin And Co Sec | 175434470001 | ||||||||
MACLATCHY, Douglas | Director | 7902 Westpark Drive IRISH Mclean Virginia Va 22102 U S A | Canadian | Corporate Finance | 96017030001 | |||||||||
MAYR, Lisa-Beth | Director | 6010 Softwood Trail Mclean Virginia 22101 | United States | American | Treasurer And Svp | 214324110001 | ||||||||
MILLER, Jeffrey Herman | Director | House 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon United Kingdom | United States Of America | Us Citizen | Executive Vice President - Op And Gen Counsel | 171919780001 | ||||||||
MILSTEIN, Paul Scott | Director | 10916 Blue Roan Road IRISH Oakton Virginia 22124 Usa | Usa | United States | Senior President Finance | 142614120001 | ||||||||
MOAK, Thomas M | Director | 7902 Westpark Drive IRISH Mcclean Virginia United States | American | Chief Executive Officer | 94063180001 | |||||||||
NEWELL, Thomas Bruce | Director | 7902 Westpark Drive IRISH Mcclean Virginia United States | American | Attorney | 75292770002 | |||||||||
POPE, James Sulkirk | Director | Wyandot Court Bethesda LMVBKZUQ Maryland 5011 20816 United States | United States | Svp Finance | 130583780001 | |||||||||
RUSH, Bradley Burnett | Director | 371 Church St. Ne IRISH Vienna Virginia 22180 Usa | American | Chief Investment Officer | 114799100001 | |||||||||
SKIVER, Justin | Director | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England | Ohio, Usa | American | Vp, Investments | 182743080001 | ||||||||
SLAVIN, Christian B A | Director | 7902 Westpark Drive IRISH Mcclean Virginia United States | American | Executive Vice President | 94064060001 | |||||||||
EVERDIRECTOR LIMITED | Director designado corporativo | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc. | 06 abr 2016 | Dorr Street 43615 Toledo 4500 Ohio United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 30 dic 2005 Entregado el 13 ene 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due of the borrowers and each guarantor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental debenture | Creado el 12 may 2005 Entregado el 20 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrower and the company to the arranger, the agent, the chargee and the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge, all its rights under the new principal lease, by way of assignment by way of first-ranking security, all its rights under the new principal lease. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 18 feb 2004 Entregado el 25 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and the borrower to the arranger, the agent, the security trustee and the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All that f/h land known as a site comprising jonathans, chatsworth, acorn house, fourways and land adjoining croydon lane, banstead, surrey t/nos SY495884, SY220426, SY215779, SY356966 and SY194584. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene SUNRISE OPERATIONS BANSTEAD LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0