LATIMER ACQUISITIONS LIMITED

LATIMER ACQUISITIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLATIMER ACQUISITIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04966641
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LATIMER ACQUISITIONS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LATIMER ACQUISITIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northamptonshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LATIMER ACQUISITIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LATIMER ACQUISITIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2017 au 30 jun 2018

    1 páginasAA01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Richard William Thomas Martin como secretario el 11 ene 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Christopher David George Thomas como secretario el 11 ene 2018

    1 páginasTM02

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    Capitalised 09/01/2018
    RES14
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 ene 2018

    • Capital: GBP 114,071,390.00
    4 páginasSH01

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 10 ene 2018

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH06

    Estado de capital el 11 ene 2018

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account 10/01/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 12 dic 2017

    • Capital: GBP 13
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account 01/12/2017
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 17 nov 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 10-18 Union Street London SE1 1SZ United Kingdom a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 páginasAD03

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2017 au 30 sept 2017

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Giles Michael Turrell como director el 18 oct 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2016

    90 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LATIMER ACQUISITIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARTIN, Richard William Thomas
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northants
    England
    Secretario
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northants
    England
    242484560001
    ABBOTT, Sally Jane
    Station Road
    NN15 5JR Burton Latimer
    Weetabix Mills
    England
    Director
    Station Road
    NN15 5JR Burton Latimer
    Weetabix Mills
    England
    EnglandBritishDirector133862850002
    MARTIN, Richard William Thomas
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    England
    Director
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishDirector37115510005
    DARWENT, Robert
    52 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Secretario
    52 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    BritishInvestor72764480004
    MARTIN, Richard William Thomas
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    England
    British37115510005
    THOMAS, Christopher David George
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    Secretario
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    195970470001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENAZECH, Victor Francois Robert
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    England
    Director
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    England
    United KingdomFrenchInvestor189698870001
    CUI, Guiyong
    China Central Place, No. 77 Jian Guo Road
    Chaoyang District
    100025 Beijing
    Unit 2903-05a, Tower 3
    China
    Director
    China Central Place, No. 77 Jian Guo Road
    Chaoyang District
    100025 Beijing
    Unit 2903-05a, Tower 3
    China
    ChinaChineseInvestment Professional200717950001
    DARWENT, Robert
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    Director
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    BahamasBritishInvestor72764480006
    HALSTENBERG, Dominik
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    Director
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    EnglandGermanInvestment Professional114930580002
    HERBERSTEIN, Johann Maximilian
    10 Kimberley Court
    Kimberley Road
    NW6 7LS London
    Director
    10 Kimberley Court
    Kimberley Road
    NW6 7LS London
    AustrianInvestor142652310001
    LEA, Lyndon
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    Director
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    BahamasBritishInvestor121737610003
    LILI, Wang
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    Director
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseVice General Manager Of Bright Food International173520480001
    LIN, Li
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    Director
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseGeneral Manager Fince Dept Bright Food (Group)173520570001
    ROSEN, Andrew
    3006 Woodside 5011
    Dallas
    75201
    Director
    3006 Woodside 5011
    Dallas
    75201
    UsaAmericanInvestments116038870001
    SCHOFIELD, Robert John
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Redwood House
    Surrey
    England
    Director
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Redwood House
    Surrey
    England
    United KingdomBritishDirector Of Weetabix80018490003
    SURSOCK, Mike
    8 Finance Street
    Central
    Hong Kong
    Suite 3801, Two International Finance Centre
    Hong Kong
    Director
    8 Finance Street
    Central
    Hong Kong
    Suite 3801, Two International Finance Centre
    Hong Kong
    Hong KongGreekOperating Partner200717940001
    TURRELL, Giles Michael
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    England
    Director
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishDirector141655480001
    WU, Tonghong
    376 Zhao Jia Bang Road
    Xuhui District
    Shanghai
    15f
    Shanghai 200031
    Prc
    Director
    376 Zhao Jia Bang Road
    Xuhui District
    Shanghai
    15f
    Shanghai 200031
    Prc
    ChinaChineseExecutive197681400001
    XIAOFENG, Cao
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    Director
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseDirector Of Bright Food Europe Limited173520640001
    YE, Yin
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    United Kingdom
    Director
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    United Kingdom
    United States Of AmericaChineseInvestment Associate173522860001
    ZHANG, Bin
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    Director
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    ChinaChineseVp Of Shanghai No.1 Yimin Foods (Group) Co Ltd208316540001
    ZHANG, Lin
    253 Hua Shan Road
    200040 Shanghai
    No 7
    Shanghai
    Prc
    Director
    253 Hua Shan Road
    200040 Shanghai
    No 7
    Shanghai
    Prc
    PrcChineseDeputy General Manager208316480001
    ZHAO, Jianfu
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    Director
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    ChinaChineseVice Cfo208316620001
    ZONGNAN, Wang
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    20040
    P.R.China
    Director
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    20040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseDirector Of Bright Food Europe Limited173520200001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LATIMER ACQUISITIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    United Kingdom
    15 ago 2016
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04966642
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene LATIMER ACQUISITIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 26 oct 2015
    Entregado el 05 nov 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transacciones
    • 05 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    • 10 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Group debenture
    Creado el 02 nov 2012
    Entregado el 12 nov 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Rabobank International, London Branch
    Transacciones
    • 12 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 26 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Group debenture
    Creado el 22 nov 2011
    Entregado el 09 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 09 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 10 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 03 may 2007
    Entregado el 18 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transacciones
    • 18 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge
    Creado el 23 ene 2006
    Entregado el 30 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and each mezzanine finance party of any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The intellectual property rights listed in appendix e to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited or Such Other Person as May Be Appointed Security Agent and Trusteefor the Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties
    Transacciones
    • 30 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 22 dic 2005
    Entregado el 05 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and the mezzanine finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Security Agent and Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties)
    Transacciones
    • 05 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A composite guarantee & debenture
    Creado el 02 jul 2004
    Entregado el 15 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and the mezzanine finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land lying on the south side of macadam road corby t/no NN168304, f/h & l/h property being unit a & brook house brook way ivyhouse lane hastings t/no ESX217047 t/no ESX142376 t/no ESX175104, f/h land being south west side of ivyhouse lane hastings t/no ESX183907. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited for Such Other Person as May Be Appointed Security Agent and Trustee for the Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties
    Transacciones
    • 15 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 12 feb 2004
    Entregado el 27 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that f/h land k/a sites 1 and 2 earlstree industrial estate and being land and buildings at the junction of earlstrees road and rockingham road corby t/n NN134520 and NN195622, all that f/h land and buildings on the southwest side of polwell lane burton latimer t/n NN62464, NN713990 and NN86660, all that f/h land being the land lying to the west of polwell lane barton seagrave t/n NN130449, for details of further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited or Other Such Person as May Be Appointed Security Agent and Trusteefor the Finance Parties
    Transacciones
    • 27 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of charge on cash collateral deposit
    Creado el 09 dic 2003
    Entregado el 22 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The security assets being the deposit moneys the debts represented by the deposit moneys the lng cash collateral account and any rights in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    Transacciones
    • 22 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 09 dic 2003
    Entregado el 22 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All present and future assets of the of the company, land interest in land fixtures plant machinery and equipment stocks shares bonds and other securities of any kind the debts the benefit of insurances goodwill and uncalled capital intellectual property the target the scheme and the scheme documents the press release the offer and the offer documents floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    Transacciones
    • 22 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A composite guarantee and debenture dated 18TH november 2003 as amended by a supplemental deed
    Creado el 04 dic 2003
    Entregado el 05 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to J.P. morgan PLC, jpmorgan chase bank and J.P. morgan europe limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuant to Thefacilities Agreement
    Transacciones
    • 05 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0