BUSY BEES GROUP LIMITED

BUSY BEES GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBUSY BEES GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04968957
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BUSY BEES GROUP LIMITED?

    • (9305) /

    ¿Dónde se encuentra BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Busy Bees At St Matthews
    Shaftsbury Drive
    WS7 9QP Burntwood
    Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BROOMCO (3333) LIMITED19 nov 200319 nov 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Struck off register 30/09/2011
    RES13

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Adam Loren Cohn como director el 29 sept 2011

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Maslen como director el 29 sept 2011

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elanna Sharon Yalow como director el 29 sept 2011

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stanley Elliot Maron como director el 29 sept 2011

    2 páginasTM01

    Estado de capital el 29 sept 2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 29/09/2011
    RES13

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    7 páginasMG01

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    20 páginasAA

    legacy

    9 páginasMG01

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2009 au 31 dic 2009

    1 páginasAA01

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Secretario
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    British55976790005
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Director
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Director
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    British9070120002
    WAUGH, John
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    Secretario
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    New Zealander130463000001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    ANTHONY, Larry
    476 Tweed Valley Way
    Murwillumbah
    New South Wales 2484
    Australia
    Director
    476 Tweed Valley Way
    Murwillumbah
    New South Wales 2484
    Australia
    Australian119252580001
    BANNAN, Jillian Glenda
    47 Tooth Avenue
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Director
    47 Tooth Avenue
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Australian117530620001
    BARBOUR SMITH, James Kenneth Alexander
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British80175630001
    BLACK, James
    103 Howard Street
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Director
    103 Howard Street
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Australian117530480001
    COHN, Adam Loren
    Stone Canyon Road
    Los Angeles
    1221
    California Ca 90077
    Usa
    Director
    Stone Canyon Road
    Los Angeles
    1221
    California Ca 90077
    Usa
    United StatesAmerican179538540001
    GALLAGHER, Patrick
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Director
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Australian130462890001
    HORTON, Mathew
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Director
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Australian130462790001
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Director
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    MARON, Stanley Elliot
    440 21st Street
    Santa Monica
    California 90402
    Usa
    Director
    440 21st Street
    Santa Monica
    California 90402
    Usa
    United StatesAmerican94599720001
    MASLEN, Peter
    Cuscaden Road, #16-01
    Singapore
    20
    249726
    Singapore
    Director
    Cuscaden Road, #16-01
    Singapore
    20
    249726
    Singapore
    SingaporeAustralian138244750001
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Director
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Director
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    SPOTTISWOODE, Clare Mary Joan
    39 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    Director
    39 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    United KingdomBritish45303770001
    THACKRAY, David Ian
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    British9070100001
    WALSH, Julia Maria, Dr
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    Director
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    UkBritish47545490001
    WAUGH, John
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    Director
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    New Zealander130463000001
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Director
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish3850190004
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish3850190004
    YALOW, Elanna Sharon
    Holcomb Avenue
    Larkspur
    427
    California Ca94939
    United States
    Director
    Holcomb Avenue
    Larkspur
    427
    California Ca94939
    United States
    UsaUnited States138244770001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ¿Tiene BUSY BEES GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite debenture
    Creado el 21 dic 2010
    Entregado el 30 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 30 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 22 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental charge
    Creado el 04 mar 2010
    Entregado el 06 mar 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The shares and the related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transacciones
    • 06 mar 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 09 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession
    Creado el 05 jun 2009
    Entregado el 16 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Princess christian college wilbraham road fallowfields manchester. Chester street, aston lock south birmingham, land on the west side of manton lane bedford. For further properties please see form 395 see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 11 may 2005
    Entregado el 14 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the noteholders or to the trustee (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barrington House Nominees Limited
    Transacciones
    • 14 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 23 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 10 jun 2004
    Entregado el 24 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    1 (one) ordinary share of £1 issued by broomco (3347) limited (co no 4968447 together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 27 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 09 jun 2004
    Entregado el 24 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    70,000 a ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees hroup limited (co no 3895685); 900 b ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685; 2 c ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 27 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 09 jun 2004
    Entregado el 24 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    600,000 ordinary shares of £1.00 each issued by burntwood holdings limited )co no 03840104) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 27 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 jun 2004
    Entregado el 24 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 27 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0