CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED

CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCONTINENTAL SHELF 291 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04978146
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    16 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 06 ago 2018

    12 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 06 ago 2017

    13 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 06 ago 2016

    7 páginas4.68

    Declaración de solvencia

    5 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de 18th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW a 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE el 21 ago 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 07 ago 2015

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Gary John Mccabe como director el 21 abr 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2015

    4 páginasAA

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 27 dic 2014

    16 páginasRP04

    Cese del nombramiento de Malcolm Robin Turner como director el 24 nov 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2015

    Estado de capital el 06 ene 2015

    • Capital: GBP 20,250,000
    SH01
    capital06 ene 2015

    Estado de capital el 26 ene 2015

    • Capital: GBP 19,990,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Stephane Abraham Joseph Nahum como director el 24 nov 2014

    2 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 02 dic 2014

    • Capital: GBP 19,990,000
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr Christakis Christofi como director el 01 jun 2014

    3 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014

    4 páginasAA

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ene 2014

    Estado de capital el 14 ene 2014

    • Capital: GBP 20,250,000
    SH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2012

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    Secretario
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    British67125820002
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    10
    England
    Director
    Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    10
    England
    EnglandBritish67125820002
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Secretario
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    British141163370001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secretario designado corporativo
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Director
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Director
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Director
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritish61386600003
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Director
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    British94163020001
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    Scotland
    Director
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish139525550001
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    Director
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    ScotlandBritish139525550001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Director
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    Director
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    EnglandFrench99292580003
    SELLAR, Gillian Christine
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    British107180940001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Director
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritish141163390001
    TURNER, Malcolm Robin
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    Director
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    United KingdomBritish60293070001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Director designado corporativo
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    ¿Tiene CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 04 mar 2004
    Entregado el 19 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of a first floating charge the whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the charge.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee and Agent for the Financeparties
    Transacciones
    • 19 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2003
    Entregado el 31 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 31 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    07 ago 2015Inicio de la liquidación
    15 feb 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Newman
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Profesional
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Vincent John Green
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Profesional
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0