AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 04985335 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?
| Dirección de la sede social | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HORIZON GROUP FINANCING LIMITED | 04 dic 2003 | 04 dic 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Phillimore Clifford como director el 28 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Sui Sang Leung como director el 22 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Henry Maxwell Oliver como director el 22 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Stuart Wilcox como director el 22 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic Gibb como director el 22 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hilke Farina como director el 22 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Chris Blease como director el 22 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Amicushorizon Limited el 22 may 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 15 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 dic 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 dic 2015, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Hilke Farina como director el 21 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Stuart Wilcox como director el 01 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIVO | Secretario corporativo | 125 High Street CR0 9XP Croydon Grosvenor House Surrey United Kingdom |
| 81186300007 | ||||||||||||||
| EVANS, Daniel | Secretario | Trowers & Hamlins Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | British | 94303280001 | ||||||||||||||
| AARONS, Leslie Ian | Director | Briarwood House 11 Briarwood Hill CR8 3LF Purley Surrey | British | 103151160001 | ||||||||||||||
| BAKER, Trevor Charles | Director | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 26767780006 | ||||||||||||||
| BLEASE, Chris | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 174349810001 | |||||||||||||
| BURKE, Martin Joseph | Director | 31 Garrard Road SM7 2ER Banstead Surrey | England | British | 80091720001 | |||||||||||||
| CAMPBELL, Rory Gerald Peter | Director | Trowers & Hamlins Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | British | 94303270001 | ||||||||||||||
| CHILEMBA, Harneck | Director | 112b Erlanger Road Telegraph Hill Park SE14 5TJ London | Malawian | 96356850001 | ||||||||||||||
| CLIFFORD, David Phillimore | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 197049630001 | |||||||||||||
| COOPER, Peter Harry | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 100351860001 | |||||||||||||
| CRUTTENDEN, Peter | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 79421300001 | |||||||||||||
| CUDD, John Charles | Director | 4 Walnut Tree Walk BN20 9BP Eastbourne East Sussex | England | British | 113934990001 | |||||||||||||
| DICKINSON MA, David John | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 139132630001 | |||||||||||||
| EVANS, Daniel | Director | Trowers & Hamlins Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | British | 94303280001 | ||||||||||||||
| FALCONER, Charles Leslie, Lord | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 36324370001 | |||||||||||||
| FARINA, Hilke | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | Irish | 200319020001 | |||||||||||||
| GIBB, Dominic | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 187068870001 | |||||||||||||
| HARLAND, Stuart | Director | Knellstone House Udimore TN31 6AR Rye East Sussex | British | 114759590001 | ||||||||||||||
| HARRIOTT, Stephen | Director | 6 Quay Court Westmeads Road CT5 1QZ Whitstable Kent | British | 113561590001 | ||||||||||||||
| HOLES, Eric | Director | 2 Stable Courtyard Chelwood Vachery TN22 3HR Nutley East Sussex | England | British | 90452390001 | |||||||||||||
| INGRAM, Owen | Director | 6 Arbor Close BR3 6TW Beckenham Kent | United Kingdom | British | 103630530001 | |||||||||||||
| KOTTEGODA, Siraj, Mr. | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 99206180001 | |||||||||||||
| LEUNG, Stephen Sui Sang | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 196161690001 | |||||||||||||
| NEWSAM, Denise Feshina Philippa | Director | 32 Garlies Road Forest Hill SE23 2RT London | United Kingdom | British | 96357030001 | |||||||||||||
| OLASODE, Olusegun Ayodeji, Dr | Director | New Orchard House 2a Monks Orchard Road, West Wickham BR3 3BW Beckenham Kent | United Kingdom | British | 52287010003 | |||||||||||||
| OLIVER, David Henry Maxwell | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 67052550001 | |||||||||||||
| PANTER, Andrew | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 52734470001 | |||||||||||||
| SMITH, Dennis Michael | Director | Treetops 57 Battery Hill Fairlight TN35 4AP Hastings East Sussex | United Kingdom | British | 69832870003 | |||||||||||||
| SMITH, Sarah Anne | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 127972360001 | |||||||||||||
| STARKE, Christopher Charles | Director | 35 Byng Road TN4 8EG Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 62786710003 | |||||||||||||
| WALKER, Stephen | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | Uk | British | 113110240002 | |||||||||||||
| WILCOX, Simon Stuart | Director | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 198724310001 | |||||||||||||
| WILSON, Ben | Director | Apartment 17 Tower 1 416 Manchester Road E14 3RD London | England | British | 90171030001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 04 dic 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge | Creado el 06 ene 2011 Entregado el 13 ene 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First fixed charge all the chargor's rights title and interest from time to time in and to each of the following assets the facilities account and all moneys now or at any time in future standing to the credit of the facilities account see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 17 dic 2010 Entregado el 22 dic 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first floating charge the whole of the chargor's undertaking and assets present and future all rights and claims to which the chargor is now or may hereafter become entitled in relation to all moneys now or at any time hereafter standing to the credit of the agf sinking fund together with all the rights relating of attaching hereto see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed charge | Creado el 14 feb 2007 Entregado el 02 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All the right title and interest from time to time in and to each of the following assets, the facilities account and all rights and claims in relation to all moneys. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 26 mar 2004 Entregado el 15 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights and claims in relation to all moneys standing to the credit of the hgf sinking fund together with all rights relating or attaching thereto, all rights of the chargor under or in respect of the documents,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0