AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED

AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 04985335
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HORIZON GROUP FINANCING LIMITED 04 dic 200304 dic 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de David Phillimore Clifford como director el 28 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Stephen Sui Sang Leung como director el 22 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Henry Maxwell Oliver como director el 22 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Stuart Wilcox como director el 22 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Dominic Gibb como director el 22 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Hilke Farina como director el 22 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Chris Blease como director el 22 may 2017

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Amicushorizon Limited el 22 may 2017

    1 páginasCH04

    Memorándum y Estatutos

    15 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de confirmación presentada el 04 dic 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 dic 2015, aucune liste de membres fournie

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    14 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Hilke Farina como director el 21 may 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon Stuart Wilcox como director el 01 may 2015

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OPTIVO
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Forma jurídicaCOMMUNITY BENEFIT SOCIETY
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalCO-OPERATIVE & COMMUNITY BENEFIT ACT 2011
    Número de registro7561
    81186300007
    EVANS, Daniel
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Secretario
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303280001
    AARONS, Leslie Ian
    Briarwood House
    11 Briarwood Hill
    CR8 3LF Purley
    Surrey
    Director
    Briarwood House
    11 Briarwood Hill
    CR8 3LF Purley
    Surrey
    British103151160001
    BAKER, Trevor Charles
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British26767780006
    BLEASE, Chris
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish174349810001
    BURKE, Martin Joseph
    31 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    Director
    31 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    EnglandBritish80091720001
    CAMPBELL, Rory Gerald Peter
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Director
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303270001
    CHILEMBA, Harneck
    112b Erlanger Road
    Telegraph Hill Park
    SE14 5TJ London
    Director
    112b Erlanger Road
    Telegraph Hill Park
    SE14 5TJ London
    Malawian96356850001
    CLIFFORD, David Phillimore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish197049630001
    COOPER, Peter Harry
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish100351860001
    CRUTTENDEN, Peter
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish79421300001
    CUDD, John Charles
    4 Walnut Tree Walk
    BN20 9BP Eastbourne
    East Sussex
    Director
    4 Walnut Tree Walk
    BN20 9BP Eastbourne
    East Sussex
    EnglandBritish113934990001
    DICKINSON MA, David John
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish139132630001
    EVANS, Daniel
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Director
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303280001
    FALCONER, Charles Leslie, Lord
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish36324370001
    FARINA, Hilke
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandIrish200319020001
    GIBB, Dominic
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish187068870001
    HARLAND, Stuart
    Knellstone House
    Udimore
    TN31 6AR Rye
    East Sussex
    Director
    Knellstone House
    Udimore
    TN31 6AR Rye
    East Sussex
    British114759590001
    HARRIOTT, Stephen
    6 Quay Court
    Westmeads Road
    CT5 1QZ Whitstable
    Kent
    Director
    6 Quay Court
    Westmeads Road
    CT5 1QZ Whitstable
    Kent
    British113561590001
    HOLES, Eric
    2 Stable Courtyard
    Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Director
    2 Stable Courtyard
    Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish90452390001
    INGRAM, Owen
    6 Arbor Close
    BR3 6TW Beckenham
    Kent
    Director
    6 Arbor Close
    BR3 6TW Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish103630530001
    KOTTEGODA, Siraj, Mr.
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish99206180001
    LEUNG, Stephen Sui Sang
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish196161690001
    NEWSAM, Denise Feshina Philippa
    32 Garlies Road
    Forest Hill
    SE23 2RT London
    Director
    32 Garlies Road
    Forest Hill
    SE23 2RT London
    United KingdomBritish96357030001
    OLASODE, Olusegun Ayodeji, Dr
    New Orchard House
    2a Monks Orchard Road, West Wickham
    BR3 3BW Beckenham
    Kent
    Director
    New Orchard House
    2a Monks Orchard Road, West Wickham
    BR3 3BW Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish52287010003
    OLIVER, David Henry Maxwell
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish67052550001
    PANTER, Andrew
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish52734470001
    SMITH, Dennis Michael
    Treetops 57 Battery Hill
    Fairlight
    TN35 4AP Hastings
    East Sussex
    Director
    Treetops 57 Battery Hill
    Fairlight
    TN35 4AP Hastings
    East Sussex
    United KingdomBritish69832870003
    SMITH, Sarah Anne
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish127972360001
    STARKE, Christopher Charles
    35 Byng Road
    TN4 8EG Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    35 Byng Road
    TN4 8EG Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish62786710003
    WALKER, Stephen
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    UkBritish113110240002
    WILCOX, Simon Stuart
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Director
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish198724310001
    WILSON, Ben
    Apartment 17 Tower 1
    416 Manchester Road
    E14 3RD London
    Director
    Apartment 17 Tower 1
    416 Manchester Road
    E14 3RD London
    EnglandBritish90171030001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    04 dic 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed charge
    Creado el 06 ene 2011
    Entregado el 13 ene 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge all the chargor's rights title and interest from time to time in and to each of the following assets the facilities account and all moneys now or at any time in future standing to the credit of the facilities account see image for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 13 ene 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 11 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 17 dic 2010
    Entregado el 22 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge the whole of the chargor's undertaking and assets present and future all rights and claims to which the chargor is now or may hereafter become entitled in relation to all moneys now or at any time hereafter standing to the credit of the agf sinking fund together with all the rights relating of attaching hereto see image for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 22 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 11 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed charge
    Creado el 14 feb 2007
    Entregado el 02 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the right title and interest from time to time in and to each of the following assets, the facilities account and all rights and claims in relation to all moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transacciones
    • 02 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 11 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 26 mar 2004
    Entregado el 15 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights and claims in relation to all moneys standing to the credit of the hgf sinking fund together with all rights relating or attaching thereto, all rights of the chargor under or in respect of the documents,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries
    Transacciones
    • 15 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 11 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0