BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED

BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05018017
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KAMAN COMPOSITES - UK HOLDINGS LIMITED20 ene 201120 ene 2011
    BROOKHOUSE HOLDINGS LIMITED13 may 200413 may 2004
    INHOCO 3035 LIMITED16 ene 200416 ene 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Estado de capital el 10 ene 2022

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 13/12/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 050180170004

    1 páginasMR04

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2020 au 31 mar 2021

    1 páginasAA01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name05 mar 2021

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 05 mar 2021

    RES15

    Nombramiento de Mr Christopher John Morris como director el 02 feb 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Matthew Paul Rossiter como director el 02 feb 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Nord Aerospace Bidco Limited como director el 02 feb 2021

    3 páginasAP02

    Memorándum y Estatutos

    15 páginasMA

    Memorándum y Estatutos

    15 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Ian Kennard Walsh como director el 02 feb 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert Daniel Starr como director el 02 feb 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael James Lyon como director el 02 feb 2021

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 050180170004, creada el 02 feb 2021

    10 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 16 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    21 páginasAA

    Nombramiento de Ian Kennard Walsh como director el 01 oct 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORRIS, Christopher John
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    India Mill Business Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    India Mill Business Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish279772890001
    ROSSITER, Matthew Paul
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    India Mill Business Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    India Mill Business Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish279773100001
    NORD AEROSPACE BIDCO LIMITED
    74a Charlotte Street
    W1T 4QJ London
    Ariel House
    United Kingdom
    Director corporativo
    74a Charlotte Street
    W1T 4QJ London
    Ariel House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro13075532
    279785870001
    MCCAY, Michael
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    Secretario
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    150894090001
    THOMAS, Guy
    Heathercombe Goodshaw Lane
    Crawshawbooth
    BB4 8DJ Rossendale
    Lancashire
    Secretario
    Heathercombe Goodshaw Lane
    Crawshawbooth
    BB4 8DJ Rossendale
    Lancashire
    British243854970002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BARNHART, Richard Roman
    Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    1332
    Connecticut
    United States
    Director
    Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    1332
    Connecticut
    United States
    United StatesAmerican238701340001
    CLARK, Candace
    Waterville Road
    Avon
    Connecticut
    290
    06001
    Usa
    Director
    Waterville Road
    Avon
    Connecticut
    290
    06001
    Usa
    United States131481860001
    COLLIS, Michael Christopher
    145 Holme Road
    NG2 5AG West Bridgford
    Nottinghamshire
    Director
    145 Holme Road
    NG2 5AG West Bridgford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish92105960001
    DAWSON, Timothy Hugh
    St Leonards Close
    Harrogate
    HG2 8NU North Yorkshire
    4
    United Kingdom
    Director
    St Leonards Close
    Harrogate
    HG2 8NU North Yorkshire
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritish189597670001
    DENNINGER, William C
    Roxbury Road
    06902 Stamford
    231
    Conneticut
    Usa
    Director
    Roxbury Road
    06902 Stamford
    231
    Conneticut
    Usa
    UsaUsa135136300001
    GARNEAU, Robert Montgomery
    47 Bittersweet Lane
    South Glastonbury Connecticut 06073
    FOREIGN Usa
    Director
    47 Bittersweet Lane
    South Glastonbury Connecticut 06073
    FOREIGN Usa
    United States48031750001
    GLENNON, Andrew Paul
    13 Broadway
    Tranmore Park Guiseley
    LS20 8JU Leeds
    Yorkshire
    Director
    13 Broadway
    Tranmore Park Guiseley
    LS20 8JU Leeds
    Yorkshire
    EnglandBritish84907350001
    GODING, Joseph
    1332 Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    Kaman Corporation
    Connecticut
    Usa
    Director
    1332 Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    Kaman Corporation
    Connecticut
    Usa
    UsaAmerican161182760001
    KEATING, Neal
    Iselworth Country Cluc Drive
    Windermere
    5057
    Florida 34786
    United States
    Director
    Iselworth Country Cluc Drive
    Windermere
    5057
    Florida 34786
    United States
    United StatesAmerican131338140001
    KENYON, Christopher
    Ladybridge Lane
    Heaton
    BL15DE Bolton
    Wayside
    United Kingdom
    Director
    Ladybridge Lane
    Heaton
    BL15DE Bolton
    Wayside
    United Kingdom
    EnglandBritish189597660001
    LAFLEUR, Michael Thomas
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    Kaman Composites Uk Ltd
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    Kaman Composites Uk Ltd
    Lancashire
    United Kingdom
    United StatesAmerican237419940001
    LARWOOD, JR, James Carl
    1332 Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    Kaman Corporation
    Connecticut
    Usa
    Director
    1332 Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    Kaman Corporation
    Connecticut
    Usa
    United StatesAmerican161182870001
    LEES, Andrew John
    4 Whitaker Green
    BB4 6RL Rawtenstall
    Lancashire
    Director
    4 Whitaker Green
    BB4 6RL Rawtenstall
    Lancashire
    British97589290001
    LOCKWOOD, John B
    c/o Kaman Corporation
    Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    1332
    Connecticut
    Usa
    Director
    c/o Kaman Corporation
    Blue Hills Avenue
    06002 Bloomfield
    1332
    Connecticut
    Usa
    UsaAmerican161183060001
    LYON, Michael James
    Blue Hills Avenue
    Bloomfield
    Ct
    1332
    Ct 06002
    United States
    Director
    Blue Hills Avenue
    Bloomfield
    Ct
    1332
    Ct 06002
    United States
    United StatesAmerican166205910001
    MCCAY, Michael John
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    Director
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    EnglandBritish27028700002
    NEWTON, Paul Michael
    Over Hall Farm
    Flag Lane
    PR26 9AD Bretherton
    Lancashire
    Director
    Over Hall Farm
    Flag Lane
    PR26 9AD Bretherton
    Lancashire
    United KingdomBritish109730120001
    NICHOLS, James
    6 Balterley Court
    CW2 5SB Balterley
    Cheshire
    Director
    6 Balterley Court
    CW2 5SB Balterley
    Cheshire
    EnglandBritish97001660002
    RATCLIFFE, Jane Catherine
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    Director
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    United KingdomBritish139843980001
    REMINGTON, Eric B
    River Boulevard
    Suffield
    953
    Connecticut 06001
    United States
    Director
    River Boulevard
    Suffield
    953
    Connecticut 06001
    United States
    United States131337980001
    SMITH, Geoffrey Francis
    Churchend House
    Chatter Street Longney
    GL2 3SN Gloucester
    Director
    Churchend House
    Chatter Street Longney
    GL2 3SN Gloucester
    EnglandBritish105381590001
    STARR, Robert Daniel
    Blue Hills Avenue
    Bloomfield
    06002 Connecticut
    1332
    United States
    Director
    Blue Hills Avenue
    Bloomfield
    06002 Connecticut
    1332
    United States
    United StatesAmerican179471330001
    STEINER, Gregory Lee
    1332 Blue Hills Avenue
    Bloomfield
    Kaman
    Connecticut
    Usa
    Director
    1332 Blue Hills Avenue
    Bloomfield
    Kaman
    Connecticut
    Usa
    UsaUsa131845020001
    STIRLING, Colin Robert
    Oakfield
    Oak Road Cowthorpe
    LS22 5EY Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Oakfield
    Oak Road Cowthorpe
    LS22 5EY Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish73958140001
    THOMAS, Guy
    Heathercombe Goodshaw Lane
    Crawshawbooth
    BB4 8DJ Rossendale
    Lancashire
    Director
    Heathercombe Goodshaw Lane
    Crawshawbooth
    BB4 8DJ Rossendale
    Lancashire
    EnglandBritish243854970002
    THORLEY, Ernest Richard
    26 Eskdale Close
    Reedley
    BB10 2SH Burnley
    Lancashire
    Director
    26 Eskdale Close
    Reedley
    BB10 2SH Burnley
    Lancashire
    United KingdomBritish14230670002
    TIPPER, Gary William
    33 The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    Lancashire
    Director
    33 The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish125160140001
    WALSH, Ian Kennard
    BB3 1AD Darwen
    India Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    BB3 1AD Darwen
    India Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United StatesAmerican275131710001
    WHEELER, Carl Stephen
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    Director
    India Mill
    India Mill Business Centre
    BB3 1AD Darwen
    Lancashire
    United KingdomBritish148688200001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    India Mill Business Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    India Mill
    BB3 1AD Darwen
    India Mill Business Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06612893
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 02 feb 2021
    Entregado el 10 feb 2021
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bellerive Spv 30 Limited
    Transacciones
    • 10 feb 2021Registro de una carga (MR01)
    • 17 jun 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 abr 2004
    Entregado el 20 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aberdeen Asset Managers Limited in Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 20 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of keyman policy
    Creado el 14 abr 2004
    Entregado el 15 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the policy with skandia assuring the life of james nichols,policy no CI1 014087616 with all bonuses,benefits and other monies thereon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 abr 2004
    Entregado el 15 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0