SG LEASING (RUBY) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SG LEASING (RUBY) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05038975 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SG LEASING (RUBY) LIMITED?
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Dirección de la sede social | One Bank Street Canary Wharf E14 4SG London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RBSSAF (22) LIMITED | 09 feb 2004 | 09 feb 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de Lindsay Ginnette Sides como director el 12 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Lethbridge Fowler como director el 12 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 050389750003 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 050389750004 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 10 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Neill Charles Proudfoot el 18 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Stephen Lethbridge Fowler el 18 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Catherine Marie Madeleine Balinska-Jundzill el 18 nov 2019 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Mr Nicholas Michael Dent el 18 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom a One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG el 18 nov 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 10 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Paul Shields como director el 20 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALINSKA-JUNDZILL, Catherine Marie Madeleine | Secretario | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | 216771450001 | |||||||||||
| DENT, Nicholas Michael | Director | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | United Kingdom | British | 43922780002 | |||||||||
| PROUDFOOT, Neill Charles | Director | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | United Kingdom | British | 155380760003 | |||||||||
| DOWN, Carolyn Jean | Secretario | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700004 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Secretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24-25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Director | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Director | The Promonade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CHEESMAN, Philip Antony | Director | Great Tower Street EC3P 3HX London 5-10 England | England | British | 157812490001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Director | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| COOK, Stuart Donald | Director | Tower Hill EC3N 4SG London Sg House 41 United Kingdom | United Kingdom | British | 191477240004 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Director | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Director | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| FOWLER, Stephen Lethbridge | Director | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | England | British | 135237620002 | |||||||||
| GEORGIOU, Andreas | Director | Little Hallingbury Bishops Stortford CM22 7RJ Herts The Lodge, Goose Lane England | British | 88113470002 | ||||||||||
| LATTER, William Vaughan | Director | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| LOCKER, Graham Richard | Director | Stratfirld Drive EN10 7NU Broxbourne 19 Hertfordshire | British | 132992690001 | ||||||||||
| PEARCE, Nigel | Director | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| SHIELDS, Paul, Mr. | Director | Sg House 41 Tower Hill EC3N 4SG London C/O Group Legal United Kingdom | England | British | 244361960001 | |||||||||
| SIDES, Lindsay Ginnette | Director | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | England | British | 212141970001 | |||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Director | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 | |||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Director | Berberry Drive MK45 5ER Flitton 10 Bedfordshire England | England | British | 111421900001 | |||||||||
| TUBB, Philip Anthony | Director | 15 Mardleybury Road SG3 6SG Datchworth Hertfordshire | British | 98115740001 | ||||||||||
| VARNAVIDES, Lambros | Director | Cedars 24 Uphill Road Mill Hill NW7 4RB London | England | British | 33245340001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société Générale | 30 sept 2016 | Boulevard Haussmann 75009 Paris 29 France | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SG LEASING (RUBY) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 13 oct 2016 Entregado el 17 oct 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 30 sept 2016 Entregado el 17 oct 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A standby security assignment (lng carrier hull no 1778) | Creado el 31 mar 2005 Entregado el 12 abr 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title interest and benefits in and to the put option agreement the novation agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A standby proceeds account charge (lng carrier hull no 1778) | Creado el 31 mar 2005 Entregado el 12 abr 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All monies standing to the credit of the standby proceeds account (interest bearing dollar account of the company with the chargee account number RBSPBS78) and any other account deemed to be the standby proceeds account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0