TOTFC LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTOTFC LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05040327
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TOTFC LIMITED?

    • Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra TOTFC LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Geoffrey Martin & Co 3rd Floor
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TOTFC LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE TANFIELD FOOD COMPANY LIMITED12 ago 200412 ago 2004
    THE GREAT NORTHEASTERN FOOD COMPANY LIMITED23 mar 200423 mar 2004
    EVER 2304 LIMITED10 feb 200410 feb 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TOTFC LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOTFC LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    18 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 jul 2019

    17 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 4 Carlton Court Brown Lane West Leeds LS12 6LT a C/O Geoffrey Martin & Co 3rd Floor One Park Row Leeds LS1 5HN el 11 feb 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 jul 2018

    18 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Presentación de insolvencia

    INSOLVENCY:Original C.O. to defer
    1 páginasLIQ MISC

    Aplazamiento de la disolución (voluntario)

    2 páginasCOLIQ

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    14 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 19 oct 2016

    12 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Hownsgill Park Consett Co Durham DH8 7NU a 4 Carlton Court Brown Lane West Leeds LS12 6LT el 06 nov 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 20 oct 2015

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 10 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    12 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 abr 2015

    Estado de capital el 07 abr 2015

    • Capital: GBP 9,011,206
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Muckle Llp Time Central 32 Gallowgate Newcastle upon Tyne NE1 4BF United Kingdom a Unit 2C Hownsgill Industrial Park Knitsley Lane Consett County Durham DH8 7NU

    1 páginasAD02

    Cese del nombramiento de Muckle Secretary Limited como secretario el 10 feb 2015

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Miss Anita Clementson como secretario el 10 feb 2015

    2 páginasAP03

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 3

    2 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 8

    2 páginasMR05

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed the tanfield food company LIMITED\certificate issued on 14/01/15
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 13 nov 2014

    RES15

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 mar 2014

    21 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TOTFC LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CLEMENTSON, Anita
    3rd Floor
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    C/O Geoffrey Martin & Co
    Secretario
    3rd Floor
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    C/O Geoffrey Martin & Co
    196505090001
    ALLISON, David Geoffrey
    Fearnley Avenue
    WF5 9ET Ossett
    14
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Fearnley Avenue
    WF5 9ET Ossett
    14
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108595540001
    GRAY, Stephen John
    3rd Floor
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    C/O Geoffrey Martin & Co
    Director
    3rd Floor
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    C/O Geoffrey Martin & Co
    EnglandBritish147134590001
    REICHENBERGER, Wolfgang
    Buckingham Palace Road
    SW1W 9TR London
    158
    England
    Director
    Buckingham Palace Road
    SW1W 9TR London
    158
    England
    BahamasSwiss,Austrian167736250001
    BLAXALL, Christopher Stanley
    14 Front Street
    NE45 5AP Corbridge
    Northumberland
    Secretario
    14 Front Street
    NE45 5AP Corbridge
    Northumberland
    British113538620001
    FIELD, Geoffrey
    20 Millford Way
    Bowburn
    DH6 5DE Durham
    County Durham
    Secretario
    20 Millford Way
    Bowburn
    DH6 5DE Durham
    County Durham
    British13305580001
    WILLIAMS, Cassandra
    14 Neville Close
    Gainford
    DL2 3DF Darlington
    County Durham
    Secretario
    14 Neville Close
    Gainford
    DL2 3DF Darlington
    County Durham
    British121772960001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secretario designado corporativo
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    MUCKLE SECRETARY LIMITED
    Time Central
    32 Gallogate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    Secretario corporativo
    Time Central
    32 Gallogate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5276019
    101749170003
    NORHAM HOUSE SECRETARY LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    Secretario corporativo
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    101749170001
    ABRAHAM, Berony Anne
    Bails Lodge
    Hartley
    CA17 4JJ Kirkby Stephen
    Cumbria
    Director
    Bails Lodge
    Hartley
    CA17 4JJ Kirkby Stephen
    Cumbria
    United KingdomBritish23220450002
    ANDREWS, Mark Stuart
    c/o Inventages
    Buckingham Palace Road
    SW1W 9TR London
    156-158
    Director
    c/o Inventages
    Buckingham Palace Road
    SW1W 9TR London
    156-158
    United KingdomBritish148101300002
    BLAXALL, Christopher Stanley
    14 Front Street
    NE45 5AP Corbridge
    Northumberland
    Director
    14 Front Street
    NE45 5AP Corbridge
    Northumberland
    British113538620001
    CRITTENDEN, Nicola Louise
    44 Springbank Road
    Sandyford
    NE2 1PD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    44 Springbank Road
    Sandyford
    NE2 1PD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British100439180002
    DHANRAJGIR, Ashok
    Buckingham Palace Road
    SW1W 9TR London
    158
    Director
    Buckingham Palace Road
    SW1W 9TR London
    158
    United KingdomIndian151117150001
    GILL, Keith Francis
    27 Front Street
    Lanchester Village
    DH7 0LA Durham
    County Durham
    Director
    27 Front Street
    Lanchester Village
    DH7 0LA Durham
    County Durham
    EnglandBritish44828130001
    HARPER, Richard John
    Chaytor House Parklands Hall
    Castle Eden
    TS27 4SN Hartlepool
    Cleveland
    Director
    Chaytor House Parklands Hall
    Castle Eden
    TS27 4SN Hartlepool
    Cleveland
    UkBritish78599250002
    LEPKOWSKI, Stefan Karol
    The Apartment
    Karol Marketing The Old Pub
    NE6 1LR East Quayside Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    The Apartment
    Karol Marketing The Old Pub
    NE6 1LR East Quayside Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish112070710001
    MCARDLE, Mark Henry
    26 Brackenpeth Mews
    Melbury Gosforth
    NE3 5RS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    26 Brackenpeth Mews
    Melbury Gosforth
    NE3 5RS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish107414540001
    MCKECHNIE, Roger Antony Nigel
    Dilston House
    NE45 5RH Corbridge
    Northumberland
    Director
    Dilston House
    NE45 5RH Corbridge
    Northumberland
    United KingdomBritish16028130002
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Director
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritish134995270001
    SIEBER, Erich
    c/o Inventages Venture Capital
    Route De Coppet
    1291 Commugny
    26a
    Switzerland
    Director
    c/o Inventages Venture Capital
    Route De Coppet
    1291 Commugny
    26a
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss148472110001
    SMITH, John David
    38 Reid Park Road
    Jesmond
    NE2 2ES Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    38 Reid Park Road
    Jesmond
    NE2 2ES Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish12210060001
    STRANG, Thomas
    8 The Grove
    YO24 1XD York
    North Yorkshire
    Director
    8 The Grove
    YO24 1XD York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish105763090001
    WILLIAMS, Cassandra
    14 Neville Close
    Gainford
    DL2 3DF Darlington
    County Durham
    Director
    14 Neville Close
    Gainford
    DL2 3DF Darlington
    County Durham
    British121772960001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Director designado corporativo
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    ¿Tiene TOTFC LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 jun 2011
    Entregado el 20 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • W. Health L.P.
    Transacciones
    • 20 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 15 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 02 mar 2011
    Entregado el 05 mar 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Close Invoice Finance LTD
    Transacciones
    • 05 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 07 abr 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 15 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 01 oct 2010
    Entregado el 08 oct 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge with full title guarantee the right's and interest in the rent deposit see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bizspace Limited
    Transacciones
    • 08 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    Floating charge
    Creado el 13 ago 2010
    Entregado el 19 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including all heritable property in scotland see image for full details.
    Personas con derecho
    • State Securities PLC
    Transacciones
    • 19 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental chattel mortgage
    Creado el 13 ago 2010
    Entregado el 18 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all non-vesting assets, all future guarantees, warranties and servicing and maintenance agreements in relation to the assets being levati foodtech steam heated sterilization retort (yom 2002) 16KW, 4 basket capacity 22 mins to 60 mins sterilization programmes, serial no. Matricola C11842 schema SE-1390-1; ten (10) off 11 tray retort basket mounted on trollies serial no. (For details of further assets charged, please refer to the MG01 document).
    Personas con derecho
    • State Securities PLC
    Transacciones
    • 18 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    The lease
    Creado el 23 mar 2010
    Entregado el 26 mar 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £10,584 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Rights and interest in the rent deposit see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bizspace Limited
    Transacciones
    • 26 mar 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 24 jul 2007
    Entregado el 03 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 15 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    All asset debenture
    Creado el 11 sept 2006
    Entregado el 13 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 13 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 21 abr 2005
    Entregado el 27 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene TOTFC LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 oct 2015Inicio de la liquidación
    29 abr 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    James Sleight
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    West Yorkshire
    James Sleight
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    West Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0