DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05048856
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INTERCEDE 1923 LIMITED19 feb 200419 feb 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 mar 2015

    Estado de capital el 16 mar 2015

    • Capital: GBP 18,333
    SH01

    legacy

    6 páginasSH20

    Estado de capital el 05 ene 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    6 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduction in the additional paid in capital 14/12/2014
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Estado de capital el 26 feb 2014

    • Capital: GBP 18,333
    4 páginasSH19

    legacy

    6 páginasSH20

    legacy

    6 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduction in share premium & capital contribution 10/02/2014
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Robert Theron Brockman como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Carlan Cooper como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Terry Wallace Jones como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Norman Tommy Barras como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Dan Steven Agan como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Secretario
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    AmericanDirector121496770001
    AGAN, Dan Steven
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanVice President84053880001
    BARRAS, Norman Tommy
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanVice President84053860001
    BROCKMAN, Robert Theron
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanPresident158497330001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Director
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmericanTreasurer121495910001
    COOPER, Carlan Max
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    UsaUnited StatesVice President136536270001
    JONES, Terry Wallace
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanVice President84053830001
    NALLEY, Robert Maxey
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanExecutive Vice President84053700001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Secretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    AMIES, Colin Macdonald
    Manor House
    Docking
    PE31 8WA Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    Manor House
    Docking
    PE31 8WA Kings Lynn
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director35493030002
    FORSYTH, Andrew James
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director64591610001
    GESWEIN, Gregory Thomas
    3625 Wood Hollow
    Dayton
    Ohio 45429
    Usa
    Director
    3625 Wood Hollow
    Dayton
    Ohio 45429
    Usa
    AmericanCompany Director114993100001
    GLOVER, Christopher Richard
    Brooklands
    St Marks Road
    TN2 5LU Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Brooklands
    St Marks Road
    TN2 5LU Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChairman105392300001
    GUJRAL, Ben
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    Director
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant94654870001
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Director
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmericanAccountant121496770001
    PALMER, Nicholas Edward
    30 Park Hill Road
    Otford
    TN14 5QH Sevenoaks
    Kent
    Director
    30 Park Hill Road
    Otford
    TN14 5QH Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishCeo96301840001
    SAVAGE, John Richard
    Primrose Bank Brooks Lane
    Bosley
    SK11 0PU Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Primrose Bank Brooks Lane
    Bosley
    SK11 0PU Macclesfield
    Cheshire
    BritishDirector61675390001
    VENTURA, Douglas Michael
    3840 Winning Stakes Way
    Mason
    Ohio 45040
    Usa
    Director
    3840 Winning Stakes Way
    Mason
    Ohio 45040
    Usa
    AmericanCompany Director111985510001
    YAPP, Stephen
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    Director
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritishCompany Director42686850001
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Director corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    80754520001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Director corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001

    ¿Tiene DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 11 oct 2005
    Entregado el 21 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 12 mar 2004
    Entregado el 01 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0