DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05048856 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
INTERCEDE 1923 LIMITED | 19 feb 2004 | 19 feb 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 6 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 05 ene 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 6 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 26 feb 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 6 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 6 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2013 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Theron Brockman como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Carlan Cooper como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Terry Wallace Jones como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Norman Tommy Barras como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Dan Steven Agan como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSS, Michael Craig | Secretario | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | American | Director | 121496770001 | |||||
AGAN, Dan Steven | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Vice President | 84053880001 | ||||
BARRAS, Norman Tommy | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Vice President | 84053860001 | ||||
BROCKMAN, Robert Theron | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | President | 158497330001 | ||||
BURNETT, Robert David | Director | Post Oak Run 77355 Magnolia 28122 Texas Usa | United States | American | Treasurer | 121495910001 | ||||
COOPER, Carlan Max | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | Usa | United States | Vice President | 136536270001 | ||||
JONES, Terry Wallace | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Vice President | 84053830001 | ||||
NALLEY, Robert Maxey | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Executive Vice President | 84053700001 | ||||
BROMLEY, Christopher Philip | Secretario | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||
AMIES, Colin Macdonald | Director | Manor House Docking PE31 8WA Kings Lynn Norfolk | United Kingdom | British | Company Director | 35493030002 | ||||
FORSYTH, Andrew James | Director | Well House Farm Pateley Bridge HG3 5NG Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Director | 64591610001 | ||||
GESWEIN, Gregory Thomas | Director | 3625 Wood Hollow Dayton Ohio 45429 Usa | American | Company Director | 114993100001 | |||||
GLOVER, Christopher Richard | Director | Brooklands St Marks Road TN2 5LU Tunbridge Wells Kent | British | Chairman | 105392300001 | |||||
GUJRAL, Ben | Director | Churchfield Lodge Churchfield Path EN8 9EG Cheshunt Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 94654870001 | |||||
MOSS, Michael Craig | Director | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | United States | American | Accountant | 121496770001 | ||||
PALMER, Nicholas Edward | Director | 30 Park Hill Road Otford TN14 5QH Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Ceo | 96301840001 | ||||
SAVAGE, John Richard | Director | Primrose Bank Brooks Lane Bosley SK11 0PU Macclesfield Cheshire | British | Director | 61675390001 | |||||
VENTURA, Douglas Michael | Director | 3840 Winning Stakes Way Mason Ohio 45040 Usa | American | Company Director | 111985510001 | |||||
YAPP, Stephen | Director | 4 The Tovells Off School Lane Ufford IP13 6HF Woodbridge Suffolk | England | British | Company Director | 42686850001 | ||||
MITRE DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 80754520001 | |||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 |
¿Tiene DCS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 11 oct 2005 Entregado el 21 oct 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 12 mar 2004 Entregado el 01 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0