CBRAIL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCBRAIL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05050256
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CBRAIL LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra CBRAIL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CBRAIL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CBRAIL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CBRAIL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginas4.71

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB a 1 More London Place London SE1 2AF el 19 dic 2014

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 nov 2014

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Lloyds Secretaries Limited como secretario el 13 nov 2014

    2 páginasAP04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 feb 2014

    Estado de capital el 19 feb 2014

    • Capital: EUR 500,000
    • Capital: GBP 1
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de Gavin White como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Neil Dewar Lewis el 23 ene 2013

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Colin Graham Dowsett como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy Durham como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    17 páginasAA

    Nombramiento de Mr Neil Dewar Lewis como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del secretario Mr Gavin White el 07 mar 2012

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    6 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de CBRAIL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02791894
    73512200003
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant152332230001
    LEWIS, Neil Dewar
    10 Old Burlington Street
    W1S 3AG London
    C/O Lw2
    United Kingdom
    Director
    10 Old Burlington Street
    W1S 3AG London
    C/O Lw2
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector103229440001
    DOWNS, Steven George
    Scarecrows
    66 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    Secretario
    Scarecrows
    66 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    British16641880002
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secretario
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Secretario
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    WHITE, Gavin Raymond
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    165229200001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritishBanker96202910001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritishBanking96202910001
    DUNCAN, Timothy
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    Director
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritishLawyer104005710001
    DURHAM, Timothy Sebastian
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritishHead Of Rail Capital152682880001
    GOOSEN, Willem
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    Director
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    DutchCommercial Director104881570002
    LEWIS, Neil Dewar
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    Director
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    EnglandBritishLawyer/Director103229440001
    MARR, Graham Peter Wilson
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Director
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritishBanker69564800002
    MORE, Gordon Lennie Truman
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    Director
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    United KingdomScottishBanker111414890002
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Director
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritishChartered Accountant94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Director
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishBanker56296720007
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Director
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishFinancial Controller56296720007
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Director
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    BritishAccountant95498730001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Director
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Director
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishHead Of Structured Asset Finan64287260001
    WALSH, Kenton
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishBanker125918020001
    WILSON, Edward Arthur
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    Director
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    United KingdomBritishBanker214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene CBRAIL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over shares
    Creado el 07 abr 2006
    Entregado el 26 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge in and to all of the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 26 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over shares
    Creado el 29 mar 2006
    Entregado el 06 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the shares and all stock shares warrents securities rights moneys and property (including the dividends interest or income thereon or wherefrom). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transacciones
    • 06 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A charge over shares
    Creado el 21 dic 2005
    Entregado el 23 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from cbrail (nordarz) limited to the bank or the chargee on any accountw hatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights title and interest in and to the shares and all stock shares warrants securities rights moneys or property (including dividends interest or income). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders
    Transacciones
    • 23 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over shares
    Creado el 27 oct 2005
    Entregado el 07 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from cbrail (ruhr-sieg) limited to the chargee or the bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the rights, title and interest in and to the shares (including the dividends). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited, as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transacciones
    • 07 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over shares
    Creado el 13 ene 2005
    Entregado el 28 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transacciones
    • 28 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A charge over shares
    Creado el 12 nov 2004
    Entregado el 19 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transacciones
    • 19 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene CBRAIL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 abr 2016Fecha de disolución
    28 nov 2014Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0