BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05075985 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Ems Ltd 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds West Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRADFORD & AIREDALE COMMUNITY SOLUTIONS LIMITED | 21 abr 2011 | 21 abr 2011 |
| BRADFORD & AIREDALE CARE PARTNERSHIPS LIMITED | 23 mar 2004 | 23 mar 2004 |
| TUNNEL SPACE LIMITED | 17 mar 2004 | 17 mar 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 11 abr 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 25 abr 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 11 abr 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
replacement-filing-of-director-appointment-with-name | 3 páginas | RP01AP01 | ||
Cese del nombramiento de Robert Maden como director el 28 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Equitix Management Services Limited como secretario el 01 nov 2025 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Rosie Ann Heron como secretario el 01 nov 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Balasingham Ravi Kumar como director el 01 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Edwin Walker como director el 01 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 23 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Daniel Marinus Maria Vermeer como director el 21 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Peter James Harding como director el 21 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kirsty O'brien como director el 02 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr David George Richardson el 02 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Jack Leonard Fowler como secretario el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Rosie Ann Heron como secretario el 03 ene 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 27 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Mr Jack Leonard Fowler el 11 ene 2022 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Dr Peter James Harding el 11 ene 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Office 4.10, 1 Aire Street Leeds LS1 4PR England a C/O Ems Ltd 2nd Floor Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ el 11 ene 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Bradford & Airedale (Lift) Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 dic 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||
¿Quiénes son los directivos de BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITIX MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom |
| 342191500001 | ||||||||||
| FITCH, Jane Angela, Dr | Director | 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Ems Ltd West Yorkshire United Kingdom | England | British | 343788630001 | |||||||||
| RAVI KUMAR, Balasingham | Director | 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Ems Ltd West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201667040026 | |||||||||
| RICHARDSON, David George | Director | 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Ems Ltd West Yorkshire United Kingdom | England | British | 99577280001 | |||||||||
| VERMEER, Daniel Marinus Maria | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 339677390001 | |||||||||
| BUCUR, George Bogdan | Secretario | Aldersgate Street EC1A 4JQ London 120 England | 253313220001 | |||||||||||
| FOWLER, Jack Leonard | Secretario | 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Ems Ltd West Yorkshire United Kingdom | 265339680001 | |||||||||||
| HERON, Rosie Ann | Secretario | 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Ems Ltd West Yorkshire United Kingdom | 318840450001 | |||||||||||
| HOYLE, Stephen William | Secretario | 110 West End Avenue HG2 9BT Harrogate North Yorkshire | British | 90826380001 | ||||||||||
| SHERIDAN, Clare | Secretario | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | 197724490001 | |||||||||||
| SUGDEN, Matthew | Secretario | 12 The Shroggs Steeton BD20 6TG Keighley West Yorkshire | British | 124384850002 | ||||||||||
| TURNBULL, Brian George | Secretario | Bridale Manor Thornton-Le-Dale YO18 7SF Pickering North Yorkshire | British | 3567880001 | ||||||||||
| ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Secretario corporativo | Charles Street Third Floor CF10 2GE Cardiff 46 South Glamorgan United Kingdom |
| 114724080001 | ||||||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 76729800001 | |||||||||||
| COMMUNITY SOLUTIONS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom |
| 160191730001 | ||||||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
| BRAIN ENGLAND, Susan Maria | Director | Beech House Vicarage Gardens Birkenshaw BD11 2EF Bradford West Yorkshire | England | British | 126626970001 | |||||||||
| CHAMBERS, Michael James | Director | 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 156008900001 | |||||||||
| CHRISTIE, Rory William | Director | Charterhouse Street EC1M 6HR London 91-93 United Kingdom | United Kingdom | British | 151812860001 | |||||||||
| COATES, Richard John | Director | 80 London Road SE1 6LH London Skipton House England | England | British | 215473490001 | |||||||||
| COX, Peter John | Director | Furnival Street EC4A 1AB London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 167445470001 | |||||||||
| CROSSLEY, Hugh Barnabas | Director | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange | United Kingdom | British | 107284040001 | |||||||||
| DAY, Mark | Director | Suite 2.02 Oxford Street M1 5AN Manchester Peter House England | England | British | 157242280001 | |||||||||
| GARLAND, Peter Leslie | Director | Curly Hill LS29 0DS Ilkley 140 West Yorkshire | United Kingdom | British | 101359640001 | |||||||||
| GOURLAY, Alastair Graham | Director | 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff Third Floor United Kingdom | England | British | 58686920001 | |||||||||
| GUNNEE, Andrew John | Director | Old Bowling Lane BD5 7JR Bradford Douglas Mill West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 102003930001 | |||||||||
| GUNNEE, Andrew John | Director | Burnside 15 Wheatley Road LS29 8TS Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | 102003930001 | |||||||||
| HARDING, David John | Director | 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House United Kingdom | England | British | 166693370001 | |||||||||
| HARDING, Peter James, Dr | Director | 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Ems Ltd West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 288230030001 | |||||||||
| HAZELGRAVE, Jane Catherine | Director | Douglas Mill Bowling Old Lane BD5 7JR Bradford Bradford Ccg West Yorkshire England | United Kingdom | British | 160407220001 | |||||||||
| HAZELGRAVE, Jane Catherine | Director | Church Gardens LS25 1HG Garforth 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 160407220001 | |||||||||
| HEAVEN, Ian Christopher | Director | Acorn Park Industrial Estate Charlestown BD17 7SW Shipley Charlestown House West Yorkshire | England | English | 83694740003 | |||||||||
| HIRST, Helen Jane | Director | Bowling Old Lane BD5 7JR Bradford Douglas Mill West Yorkshire England | England | British | 257188690001 | |||||||||
| HIRST, Helen Jane | Director | Bowling Old Lane BD5 7JR Bradford Douglas Mill West Yorkshire United Kingdom | England | British | 257188690001 | |||||||||
| HOWELL, Colin | Director | 53 Romney Close The Ings TS10 2JT Redcar Tyneside | British | 93579950001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BRADFORD & AIREDALE ESTATES PARTNERSHIP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford & Airedale (Lift) Investments Limited | 06 abr 2016 | 2nd Floor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Ems Ltd West Yorkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Community Health Partnerships Limited | 06 abr 2016 | 80 London Road SE1 6LH London Skipton House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0