BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05089367 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Dirección de la sede social | Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office 18 Town Square M33 7WZ Sale England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BLACKPOOL AIRPORT HOLDINGS LIMITED | 11 jun 2004 | 11 jun 2004 |
| MEAUJO (661) LIMITED | 31 mar 2004 | 31 mar 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ England a Mark Rebbeck - the Square Sc Management Office 18 Town Square Sale M33 7WZ el 27 ago 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Brown como director el 01 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Wolverhampton Halfpenny Green Airport Stourbridge West Midlands DY7 5DY a C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ el 28 ene 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 050893670004 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael James Brown como director el 11 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY, Noel Ferris | Secretario | 18 Town Square M33 7WZ Sale Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office England | 154493510001 | |||||||
| MURPHY, Noel Ferris | Director | 152 Warren Road BT21 0PQ Donaghadee County Down | Northern Ireland | British | 99726990001 | |||||
| HORNER, Robin George | Secretario | 4 Manor Park, Killinchy Road Comber BT23 5FW Newtownards County Down | British | 145344800001 | ||||||
| WHELAN, Paul Edward | Secretario | 5 Longheadland WR9 0JB Ombersley Worcestershire | British | 143588500001 | ||||||
| PHILSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006520001 | |||||||
| ARMSTRONG, Adam James Moore | Director | 35 Warren Road BT21 0PD Donaghadee County Down | United Kingdom | British | 184077380001 | |||||
| BROWN, Michael James | Director | c/o Diane Smith Management Office 18 Town Square M33 7WZ Sale The Square Shopping Centre Cheshire England | Northern Ireland | British | 174874620001 | |||||
| HORNER, Robin George | Director | 4 Manor Park, Killinchy Road Comber BT23 5FW Newtownards County Down | United Kingdom | British | 145344800001 | |||||
| KERSHAW, David Francis | Director | 3 Houghton Close CW9 8NW Northwich Cheshire | Uk | British | 85601560002 | |||||
| RUSH, William | Director | 140 Warren Road BT21 0PQ Donaghadee County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 99727010001 | |||||
| SILK, Graham Hampson | Director | Old Well Cottage Broome Clent DY9 0EZ Stourbridge West Midlands | England | British | 3954850001 | |||||
| WHELAN, Paul Edward | Director | 5 Longheadland WR9 0JB Ombersley Worcestershire | England | British | 143588500001 | |||||
| MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED | Director designado corporativo | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006510001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 31 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 23 dic 2013 Entregado el 04 ene 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge over bank accounts | Creado el 15 mar 2013 Entregado el 20 mar 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The account having account number 90530506 by way of fixed and floating charge all rights benefits and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of the secured account see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of assignment over deferred consideration | Creado el 01 mar 2010 Entregado el 13 mar 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from mar properties limited and mar (argyle) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of a first floating charge all the rights, title and interest referred to and insofar as such charges or any parts or the parts of the same are ineffective as specific or fixed charges see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over shares | Creado el 05 jul 2004 Entregado el 15 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The charged portfolio being all the shares in the share capital of blackpool airport business park limited and the related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0