HCCAH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHCCAH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05096889
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HCCAH LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HCCAH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HCCAH LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED01 jun 200401 jun 2004
    TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED06 abr 200406 abr 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HCCAH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HCCAH LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HCCAH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr James Alexander Burrell como director el 10 nov 2014

    2 páginasAP01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    1 páginasAA

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Registro de la carga 050968890008, creada el 12 jun 2014

    91 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 06 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 abr 2014

    Estado de capital el 07 abr 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nombramiento de Mrs Geraldine Josephine Gallagher como director el 31 ene 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Matthew Edward Bennison como director el 31 ene 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Matthew Edward Bennison como secretario el 31 ene 2014

    1 páginasTM02

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    1 páginasAA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 06 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    18 páginasMG01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    14 páginasMG01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    1 páginasAA

    Nombramiento de Mr Matthew Edward Bennison como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Matthew Edward Bennison como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy Doubleday como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de HCCAH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritish192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89557480002
    TROY, Anthony Gerard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161805270001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156121500001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secretario
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    British45253560008
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Secretario designado corporativo
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ANDERSON, Peter George
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    Director
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    British70304810001
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    British126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108534390002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Director
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Director
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PEEKE, Alexander
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    Director
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    British98031180001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    Director
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    British96079800001
    WHITE, Graham Peter
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    Director
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    United KingdomBritish4934020002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    Director
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    British61053330001

    ¿Tiene HCCAH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 12 jun 2014
    Entregado el 18 jun 2014
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transacciones
    • 18 jun 2014Registro de una carga (MR01)
    English law deed of accession
    Creado el 27 feb 2013
    Entregado el 01 mar 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 01 mar 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 27 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 dic 2011
    Entregado el 10 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 03 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession
    Creado el 18 jun 2007
    Entregado el 22 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 31 mar 2006
    Entregado el 06 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as 'Security Agent'
    Transacciones
    • 06 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003
    Creado el 24 ene 2005
    Entregado el 02 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transacciones
    • 02 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 18 dic 2003
    Adquirido el 24 ene 2005
    Entregado el 27 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders
    Breve descripción
    Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transacciones
    • 27 ene 2005Registro de una adquisición (400)
    • 04 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 14 ene 2000
    Adquirido el 24 ene 2005
    Entregado el 03 feb 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Defence
    Transacciones
    • 03 feb 2005Registro de una adquisición (400)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0