ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05113572 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
| Dirección de la sede social | C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CATALYST HEALTHCARE (LEEDS) LIMITED | 26 jul 2004 | 26 jul 2004 |
| BROOMCO (3467) LIMITED | 27 abr 2004 | 27 abr 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||
Modification des détails de St James's Oncology Spc Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 jun 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 32 páginas | AA | ||||||
Cambio de datos del director Mr Mathew Jake Grace el 28 abr 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cambio de datos del director Mr Mathew Jake Grace el 18 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Nombramiento de Mr Mathew Jake Grace como director el 28 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Frank David Laing como director el 28 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Segunda presentación para el nombramiento de Mr Johan Hendrik Potgieter como director | 3 páginas | RP04AP01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 29 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Albany Secretariat Limited como secretario el 24 jul 2023 | 2 páginas | AP04 | ||||||
Cese del nombramiento de Ailison Louise Mitchell como secretario el 24 jul 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 29 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Mr Frank David Laing como director el 01 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Andrew Leslie Tennant como director el 30 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 28 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cambio de datos del director Mr Barry Paul Millsom el 13 mar 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 28 páginas | AA | ||||||
Cambio de datos del director Mr Barry Paul Millsom el 03 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Cambio de datos del director Mr Johan Hendrik Potgieter el 28 jun 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Mr Johan Hendrik Potgieter como director el 11 ene 2021 | 3 páginas | AP01 | ||||||
| ||||||||
¿Quiénes son los directivos de ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | Charlotte Street M1 4HB Manchester 3-5 England |
| 303585870001 | ||||||||||
| GRACE, Mathew Jake | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | 295647450002 | |||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 190982570023 | |||||||||
| POTGIETER, Johan Hendrik | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | South African | 258420160002 | |||||||||
| SOLLEY, Christopher Thomas | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | 166666620001 | |||||||||
| WILLIAMS, Michael James | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 241284720001 | |||||||||
| MITCHELL, Ailison Louise | Secretario | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | British | 53150080001 | ||||||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||||||
| HLM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 1st Floor 25 Stamford Street WA14 1EX Altrincham Cheshire | 118686920001 | |||||||||||
| AMIN, Mohammed Sameer | Director | 28 Talbot Road Basement Flat W2 5LJ London | England | British | 68855640001 | |||||||||
| ANDERSON, Thomas Downs | Director | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | 54976140002 | |||||||||
| BATE, Dennis | Director | 109 Carmill Road Billinge WN5 7TY Wigan Lancashire | British | 28569910001 | ||||||||||
| CHALMERS, Douglas Charles Robert | Director | Farm Barn Gubblecote HP23 4QG Tring Gubblecote Hertfordshire | England | British | 152499570001 | |||||||||
| CHESSELLS, Arthur David, Sir | Director | Oakleigh Catts Hill TN6 3NQ Mark Cross East Sussex | England | British | 39000870003 | |||||||||
| COHEN, Gershon Daniel | Director | Trees 82 Millway NW7 3JJ London | United Kingdom | British | 77776830001 | |||||||||
| DAVIS, Michael Edward | Director | Guy Lane CH3 7RZ Waverton Stapleford House Chester | United Kingdom | British | 131261410001 | |||||||||
| DICKIE, Timothy John | Director | 51 Summerside Place EH6 4NY Edinburgh | British | 107164130002 | ||||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | United Kingdom | British | 206362380001 | |||||||||
| HOCKADAY, Stephen | Director | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | 101894100001 | |||||||||
| JACKSON, Gregor Scott | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 191227420001 | |||||||||
| LAING, Frank David | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| MCKENNA, Leo William | Director | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Lend Lease, Adamson House England | Northern Ireland | Northern Irish | 164592610001 | |||||||||
| MILLETT, Jason David | Director | Barnwell 98 Watling Street Affetside BL8 3QL Bury Lancashire | British | 68041260001 | ||||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | 156461120001 | |||||||||
| MURPHY, Helen Mary | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | Irish | 156461710001 | |||||||||
| MURPHY, Helen Mary | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | Irish | 156461710001 | |||||||||
| NEVILLE, Gary Arthur | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | 156463000001 | |||||||||
| POTGIETER, Johan Hendrik | Director | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Lend Lease, Adamson House England | England | South African | 173393140001 | |||||||||
| POTTS, Roger Harold | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | United Kingdom | British | 111244220001 | |||||||||
| TENNANT, Andrew Leslie | Director | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 95469230002 | |||||||||
| TENNANT, Andrew Leslie | Director | Rowardennan, 5 Campbell Drive Bearsden G61 4NF Glasgow Strathclyde | Scotland | British | 95469230001 | |||||||||
| TURNBULL-FOX, Moira | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | 156461580001 | |||||||||
| VELUPILLAI, Anthony Ratnam | Director | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | 152481000001 | |||||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ST JAMES'S ONCOLOGY SPC LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St James's Oncology Financing Plc | 03 sept 2016 | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0