LSL PROPERTY SERVICES PLC

LSL PROPERTY SERVICES PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLSL PROPERTY SERVICES PLC
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 05114014
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LSL PROPERTY SERVICES PLC?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra LSL PROPERTY SERVICES PLC?

    Dirección de la sede social
    First Floor, Victoria House Hampshire Court, East Newcastle Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7YJ Newcastle Upon Tyne
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LSL PROPERTY SERVICES PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LENDING SOLUTIONS LIMITED21 jul 200421 jul 2004
    BROOMCO (3455) LIMITED27 abr 200427 abr 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LSL PROPERTY SERVICES PLC?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LSL PROPERTY SERVICES PLC?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta10 jun 2026
    Próxima declaración de confirmación vence24 jun 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta10 jun 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LSL PROPERTY SERVICES PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 73,460.2236
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    12 feb 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 72,917.4276
    4 páginasSH03

    Nombramiento de David Tilak como director el 12 ene 2026

    2 páginasAP01

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 72,327.4276
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    07 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 71,717.4276
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    19 nov 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 71,277.4276
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 nov 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 71,162.3256
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 oct 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,912.3256
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    22 sept 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 71,032.3256
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    22 sept 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Cambio de datos del director Mr Christopher James Mack el 01 ago 2025

    2 páginasCH01

    legacy

    páginasANNOTATION

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,902.3256
    4 páginasSH03

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,746.3256
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    08 sept 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,626.3256
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    14 ago 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,471.9976
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    08 ago 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,311.9976
    4 páginasSH03

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,005.9716
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    14 jul 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 70,165.6276
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    14 jul 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 56,861.9716
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    11 jul 2025Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 56,935.9716
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    11 jul 2025Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 69,935.9716
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    11 jul 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Declaración de confirmación presentada el 10 jun 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Newcastle House Albany Court Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne NE4 7YB England a First Floor, Victoria House Hampshire Court, East Newcastle Business Park Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE4 7YJ el 12 jun 2025

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de autoridad para comprar un número de acciones

    RES09
    capital

    Resoluciones

    Re: general meeting (other than agm) be called on not less than 14 clear days notice 28/05/2025
    RES13
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11

    ¿Quiénes son los directivos de LSL PROPERTY SERVICES PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FISH, Deborah Ann
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    Secretario
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    327406730001
    APPLETON, Gabrielle
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    United KingdomBritish261983780001
    CASTLETON, Adam Robert
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    United KingdomBritish68631400004
    COLLINS, Adrian John Reginald
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    United KingdomBritish322910540001
    EVANS, Darrell Paul
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    United KingdomBritish256010670001
    GHOBRIAL, Sonya
    3 St. Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St. Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    EnglandBritish237076690001
    MACK, Christopher James
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    EnglandBritish159050870004
    STOOP, Michael Ian
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    United KingdomBritish62948120003
    TILAK, David
    Hampshire Court, East Newcastle Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7YJ Newcastle Upon Tyne
    First Floor, Victoria House
    England
    Director
    Hampshire Court, East Newcastle Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7YJ Newcastle Upon Tyne
    First Floor, Victoria House
    England
    United KingdomBritish344284430001
    FIELDING, Dean
    Roxberry
    Bransberry Street
    YO61 4TB Crayke
    Yorkshire
    Secretario
    Roxberry
    Bransberry Street
    YO61 4TB Crayke
    Yorkshire
    British99203580001
    FITZGERALD, Sapna Bedi
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Secretario
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    British125121390002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BARRAL, David Barclay
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    United Kingdom
    EnglandBritish265699250001
    BAYAZIT BESSON, Kumsal
    Holgate Park Drive
    YO26 4GB York
    2nd Floor, Gateway House
    England
    Director
    Holgate Park Drive
    YO26 4GB York
    2nd Floor, Gateway House
    England
    United KingdomTurkish,French200809760001
    BUCK, Helen Elizabeth
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    United KingdomBritish152893170001
    COOKE, Stephen Andrew
    Newcastle House Albany Court
    Newcastle Business Park
    NE4 7YB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    Newcastle House Albany Court
    Newcastle Business Park
    NE4 7YB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish246208860001
    CRABB, Ian Denis
    Holgate Park Drive
    YO26 4GB York
    2nd Floor, Gateway 2
    England
    Director
    Holgate Park Drive
    YO26 4GB York
    2nd Floor, Gateway 2
    England
    EnglandBritish181144470002
    EMBLEY, Simon David
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    EnglandBritish71406150003
    FIELDING, Dean Andrew
    c/o Sapna B. Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Sapna B. Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish151651130001
    GILL, Adrian Stuart
    George Cayley Drive
    Clifton Moor
    YO30 4XE York
    Buildmark House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    George Cayley Drive
    Clifton Moor
    YO30 4XE York
    Buildmark House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish66529100004
    GRIESBACH, Philip Martin
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British63348810004
    HALES, Peter John
    Shalom
    Little Brington
    NN7 4HX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Shalom
    Little Brington
    NN7 4HX Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish26035510001
    LATHAM, Paul Martin James
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish183939690001
    MATTHEWS, Roger John
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133414230001
    MORRIS, Mark Christopher
    George Cayley Drive
    Clifton Moor
    YO30 4XE York
    Buildmark House
    England
    Director
    George Cayley Drive
    Clifton Moor
    YO30 4XE York
    Buildmark House
    England
    EnglandBritish147628740001
    NEWNES, David Julian
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    Director
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    EnglandBritish75640120002
    PAIN, Mark Andrew
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish122498680001
    SHANNON, William Mervyn Frew Carey
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    Director
    3 St Mary's Court
    Blossom Street
    YO24 1AH York
    Howard House
    England
    United KingdomBritish41555570002
    SHARPE, Robert
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British79424780004
    STEWART, David
    Albany Court
    Newcastle Business Park
    NE4 7YB Newcastle Upon Tyne
    Newcastle House
    United Kingdom
    Director
    Albany Court
    Newcastle Business Park
    NE4 7YB Newcastle Upon Tyne
    Newcastle House
    United Kingdom
    EnglandBritish189076730004
    TRAVERSONI, Alison Dawn
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Sapna B Fitzgerald
    3-4 Kings Square
    YO1 8ZH York
    St. Trinity House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish151668690001
    WARBURTON, Mark Charles
    Blackacre Two
    22 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Blackacre Two
    22 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish36038570001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0