KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED

KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKNOWLES INDUSTRIAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05120790
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Canal Mill
    Botany Brow
    PR6 9AF Chorley
    Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLANMORE COOMBE HILL HOUSE LIMITED25 oct 200425 oct 2004
    SDG (NEW MALDEN 1) LIMITED29 jun 200429 jun 2004
    DWSCO 2526 LIMITED06 may 200406 may 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 05 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2016

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2016

    Estado de capital el 06 may 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2015

    16 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 ene 2015 au 30 ene 2015

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 06 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2015

    Estado de capital el 06 may 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2014

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 may 2014

    Estado de capital el 07 may 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2013

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2012

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de William Dixon como director

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2011

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2010

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Gerald Wood como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Claire Caroline Sharp como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 06 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Carrie Sharp como director

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2009

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Secretario
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    BritishProperty Director141979130001
    HOPKINSON, Thomas Duncan
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Director
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishChartered Accountant71862660002
    KNOWLES, Timothy John Peter
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Director
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishDirector33274370003
    SHARP, Claire Caroline
    Botany Brow
    PR6 9AF Chorley
    Canal Mill
    Lancashire
    Director
    Botany Brow
    PR6 9AF Chorley
    Canal Mill
    Lancashire
    EnglandBritishProperty Director141979130001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Secretario
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British85366800001
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Secretario
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    BritishSecretary141979130001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Secretario designado corporativo
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    INVESTEC ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    PO BOX 52 Investec House
    La Plaiderie St Peter Port
    GY1 3BJ Guernsey
    Channel Islands
    Secretario corporativo
    PO BOX 52 Investec House
    La Plaiderie St Peter Port
    GY1 3BJ Guernsey
    Channel Islands
    100177760001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secretario corporativo
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishConsultant1267050001
    DIXON, William Ronald
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    Director
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director136501510001
    HOWAT, Andrew Russell
    Ventris House
    La Bridage Road St Andrews
    GY6 8RQ Guernsey
    Channel Islands
    Director
    Ventris House
    La Bridage Road St Andrews
    GY6 8RQ Guernsey
    Channel Islands
    BritishManaging Director118987510001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Director
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    EnglandBritishFinancial Controller85366800001
    LEWIS, Janine
    Coco De Mer
    Folioe Lane
    GY3 5SD Vale
    Guernsey
    Channel Islands
    Director
    Coco De Mer
    Folioe Lane
    GY3 5SD Vale
    Guernsey
    Channel Islands
    BritishSupervisor Investor Services100577840001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Director56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishSurveyor109250000001
    MCCABE, Simon Charles
    5 Rothesay Mews
    EH3 7SG Edinburgh
    Director
    5 Rothesay Mews
    EH3 7SG Edinburgh
    BritishCompany Director103888320001
    MCKEAN, Michael
    Newhaven,
    Rue De Bouverie
    GY5 7TZ Castel
    Channel Islands
    Director
    Newhaven,
    Rue De Bouverie
    GY5 7TZ Castel
    Channel Islands
    BritishCompany Director100219600001
    SHARP, Carrie
    The Croft Lower Simpson Fold
    Blackburn Road
    PR6 8HL Higher Wheelton Chorley
    Lancashire
    Director
    The Croft Lower Simpson Fold
    Blackburn Road
    PR6 8HL Higher Wheelton Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishProperty Management124558490001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Director
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    WOOD, Gerald Jospeh
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    Director
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    EnglandBritishGeneral Manager110948700001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Director designado corporativo
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    First Industrial Limited
    Botany Bay
    PR6 9AF Chorley
    Botany Bay
    England
    06 abr 2016
    Botany Bay
    PR6 9AF Chorley
    Botany Bay
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act For England
    Lugar de registroCompanies House, England & Wales
    Número de registro03862895
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 01 feb 2006
    Entregado el 17 feb 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag, London Branch, in Its Capacity as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 17 feb 2006Registro de un cargo (395)
    English security agreement
    Creado el 14 sept 2004
    Entregado el 29 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 29 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 jul 2004
    Entregado el 23 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Coombe hill house, coombe lane, new maiden t/n SGL649187. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 jul 2004
    Entregado el 23 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0