MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05127535 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| OVAL (1976) LIMITED | 13 may 2004 | 13 may 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 4 páginas | 4.71 | ||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 jul 2013 | 4 páginas | 4.68 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Derek Davies como director el 14 dic 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 1, Horizon Point Swallowdale Lane Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7FZ United Kingdom el 26 sept 2012 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 11 sept 2012
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2011 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Edinburgh Pharmaceutical Industries Limited como secretario el 29 jul 2011 | 3 páginas | AP04 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Christopher Doyle como secretario el 29 jul 2011 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 abr 2012 au 31 dic 2011 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Derek Davies como director el 18 ago 2011 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 2 páginas | AD03 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 2 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Boddy como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Glaxo Group Limited como director | 2 páginas | AP02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Edinburgh Pharmaceutical Industries Limited como director | 2 páginas | AP02 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDINBURGH PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | Secretario corporativo | Shewalton Road KA11 5AP Irvine Ayrshire Scotland |
| 77321100005 | ||||||||||
| EDINBURGH PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | Director corporativo | Shewalton Road KA11 5AP Irvine Epi Ltd Ayrshire United Kingdom |
| 77321100005 | ||||||||||
| GLAXO GROUP LIMITED | Director corporativo | Berkeley Avenue UB6 0NN Greenford Glaxo Wellcome House United Kingdom |
| 17808280001 | ||||||||||
| BODDY, Peter Ashley | Secretario | The Old Rectory Church Hill Road LE16 7SN Cranoe Leicestershire | British | 101072960001 | ||||||||||
| DOYLE, Michael Christopher | Secretario | Common Wood Farnham Common SL2 3TY Slough 4 Bucks United Kingdom | British | Company Director | 138725480001 | |||||||||
| JOHN, Iain Martyn | Secretario | 48 Coleswood Road AL5 1EQ Harpenden Hertfordshire | British | Accountant | 98630830001 | |||||||||
| OVALSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||||||
| BELL, Trevor | Director | Hallands Mead End Road SO41 6EE Sway Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 92672150002 | ||||||||
| BODDY, Peter Ashley | Director | The Old Rectory Church Hill Road LE16 7SN Cranoe Leicestershire | England | British | Director | 101072960001 | ||||||||
| CURRY, Christopher John Max | Director | 41 Holland Street W8 4LX London | England | British | Investment Manager | 35538490003 | ||||||||
| DAVIES, Derek | Director | Great West Road TW8 9GS Brentford 980 Middlesex | England | British | None | 154113690001 | ||||||||
| EISENBERG, Zef | Director | Maison Du Pre Les Vardes GY1 1BG St Peter Port Guernsey | British | Director | 52171140002 | |||||||||
| GIBSON, Elizabeth | Director | 120 Woodsford Square W14 8DT London | United Kingdom | British | Consultant | 142888330001 | ||||||||
| HARRISON, Ivor John Anthony | Director | St. Peters Street Caxton CB23 3PJ Cambridge Caxton Hall Cambridgeshire United Kingdom | England | British | Director | 130461690001 | ||||||||
| HICK, Paul Arney | Director | Millcourt Mill Road SL7 1QB Marlow Buckinghamshire | England | British | Director | 47699120005 | ||||||||
| JOHN, Iain Martyn | Director | 48 Coleswood Road AL5 1EQ Harpenden Hertfordshire | British | Accountant | 98630830001 | |||||||||
| PETERS, Kevin | Director | 10 Gurnells Road HP9 2XJ Seer Green Buckinghamshire | British | Director | 75867610002 | |||||||||
| OVAL NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002560001 |
¿Tiene MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 12 dic 2007 Entregado el 19 dic 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage of life policy | Creado el 21 jun 2004 Entregado el 24 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Keyman policy in respect of ivor harrison dated 17 june 2004 issued by standard life, policy no: X75934933. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage of life policy | Creado el 21 jun 2004 Entregado el 24 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Keyman policy in respect of paul arney hick dated 17 june 2004 issued by standard life, policy no: X75934507. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage of life policy | Creado el 21 jun 2004 Entregado el 24 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Keyman policy in respect of kevin peters dated 17 june 2004 issued by standard life, policy no: X75935066. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage of life policy | Creado el 21 jun 2004 Entregado el 24 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Keyman policy in respect of iain john dated 17 june 2004 issued by standard life, policy no: X75934775. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 17 jun 2004 Entregado el 18 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene MAXIMUSCLE HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0