SKILLSMART RETAIL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SKILLSMART RETAIL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 05137619 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SKILLSMART RETAIL LIMITED?
- Regulación y contribución a un funcionamiento más eficiente de las empresas (84130) / Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
¿Dónde se encuentra SKILLSMART RETAIL LIMITED?
Dirección de la sede social | Enterprise House 21 Buckle Street E1 8NN London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SKILLSMART RETAIL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SKILLSMART RETAIL UK LIMITED | 25 may 2004 | 25 may 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SKILLSMART RETAIL LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SKILLSMART RETAIL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | 4.71 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 93 Newman Street London W1T 3EZ el 25 ene 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ramesh Jetha Shingadia como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Stephen Hooper como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Masson como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephanie Rice como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jacqui Humphries como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Patricia Doreen Deeny como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Samuel Houston Davidson como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Bell como director el 25 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicola Jane Zamblera como director el 30 sept 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Anne Seaman el 01 dic 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 may 2012, aucune liste de membres fournie | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Anne Seaman el 01 dic 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Luke Ironside como director el 21 may 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Stephen Hooper como director el 18 ene 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Samuel Houston Davidson como director el 18 ene 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Louise Masson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 may 2011, aucune liste de membres fournie | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Patricia Doreen Deeny el 16 mar 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SKILLSMART RETAIL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARR, Simon Charles Vaughan | Secretario | Buckle Street E1 8NN London Enterprise House 21 | 157201200001 | |||||||
BEAUMONT, Martin Dudley | Director | Buckle Street E1 8NN London Enterprise House 21 | United Kingdom | British | Non Executive Director | 10084840001 | ||||
DAVIS, Steven James | Director | Buckle Street E1 8NN London Enterprise House 21 | United Kingdom | British | Retail Executive | 131311030001 | ||||
MURPHY, Rebecca Henrietta | Director | Buckle Street E1 8NN London Enterprise House 21 | England | British | Hr And Marketing Director | 107609810001 | ||||
ROWLATT, Richard David | Director | Buckle Street E1 8NN London Enterprise House 21 | England | British | Retail Company Director | 28626440003 | ||||
SEAMAN, Anne | Director | Buckle Street E1 8NN London Enterprise House 21 | United Kingdom | British | Director | 110436750002 | ||||
BROOME, Nigel Stuart | Secretario | Whinfield School Road BR7 5PQ Chislehurst Kent | British | 29905480003 | ||||||
CHESHIRE, Ian Michael, Sir | Secretario | 103 Balham Park Road SW12 8EB London | British | Company Director | 7668420002 | |||||
ILLINGWORTH, Michael David Holden | Secretario | 36 Ormiston Grove W12 0JT London | British | Chartered Accountant | 105569140001 | |||||
KANJI, Sabira Mohamed | Secretario | 52 Manor Way HA2 6BY Harrow Middlesex | British,Kenyan | Accountant | 59764140001 | |||||
TARR, Simon Charles Vaughan | Secretario | 49 Weybridge Park KT13 8SQ Weybridge Surrey | British | Chartered Accountant | 70803900002 | |||||
WILSON, John Charles | Secretario | 60 Lavington Road Ealing W13 9LS London | British | Finance Director | 127749720001 | |||||
BELL, Elizabeth | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | United Kingdom | British | Hr Director | 74505610001 | ||||
BIRD, Jemima Chloe | Director | Holland Park Gardens W14 8DZ London 17a | United Kingdom | British | Marketing Director | 135893870001 | ||||
BROOME, Nigel Stuart | Director | Whinfield School Road BR7 5PQ Chislehurst Kent | British | Chief Executive | 29905480003 | |||||
CHAPMAN, Clare Moira | Director | Paper Mill House Paper Mill Lane SG11 1LD Standon Ware Hertfordshire | England | British | Group Personnel Director | 65688990001 | ||||
CHESHIRE, Ian Michael, Sir | Director | 103 Balham Park Road SW12 8EB London | England | British | Company Director | 7668420002 | ||||
COLLINS, Robert Andrew | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | England | British | Retailer | 206777980001 | ||||
DAVIDSON, Samuel Houston | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | Northern Ireland | British | Group Human Resources Director | 144864170001 | ||||
DEENY, Patricia Doreen | Director | Newman Street W1T 3EZ London 93 | United Kingdom | British | Head Of Education | 158587010001 | ||||
DRUMMOND, Robert Gordon | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | Scotland | British | None | 116114980001 | ||||
HANNETT, John | Director | 20 Hillfoot Road Wollton L25 0NB Liverpool | England | British | General Secretary Usdaw | 98867660001 | ||||
HAWKINS, Kevin | Director | 3 Cedar Drive Flowers Hill RG8 7BH Pangbourne Berkshire | British | Director General | 98136030001 | |||||
HOOPER, Christopher Stephen | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | England | British | Retail Manager | 167419170001 | ||||
HUMPHRIES, Jacqui | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | United Kingdom | British | Hr Director | 158471140001 | ||||
ILLINGWORTH, Michael David Holden | Director | 36 Ormiston Grove W12 0JT London | England | British | Chartered Accountant | 105569140001 | ||||
IRONSIDE, Thomas Luke | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | United Kingdom | British | Policy Director | 158471420001 | ||||
KELLY, Tessa Leueen Anne | Director | 18a Laurel Road SW20 0PR London | United Kingdom | British | Director | 72581930001 | ||||
KERR, Christine Gwenneth Danzey | Director | 23 Stephenson Terrace NE41 8DZ Wylam Northumberland | United Kingdom | British | Mail Order Retail Womens Cloth | 22488770001 | ||||
LOVERING, John David | Director | New House Farm Bodiam TN32 5UP Robertsbridge East Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 73573160002 | ||||
MACKENZIE, John Kenneth | Director | 37 Newton Grove Newton Mearns G77 5BX Glasgow East Nrewfrewshire | British | Chief Officer | 83787030001 | |||||
MAGINN, Cecilia Jean | Director | 12 Pineview Heights Gilford BT63 6AX Craigavon County Armagh | British | Retailer | 122647850001 | |||||
MAGINN, Cecilia Jean | Director | 12 Pineview Heights Gilford BT63 6AX Craigavon County Armagh | British | Retailer | 122647850001 | |||||
MARCHANT, Philip William | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | Uk | British | Director | 3089830010 | ||||
MASSON, Louise | Director | 93 Newman Street London W1T 3EZ | Scotland | British | General Manager | 162568180001 |
¿Tiene SKILLSMART RETAIL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Rent and service charge deposit deed | Creado el 06 ago 2007 Entregado el 16 ago 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada The deposit sum being £56,106.25 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción £56,106.25 together with all interest accrued thereto. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene SKILLSMART RETAIL LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0