SKILLSMART RETAIL LIMITED

SKILLSMART RETAIL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSKILLSMART RETAIL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 05137619
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SKILLSMART RETAIL LIMITED?

    • Regulación y contribución a un funcionamiento más eficiente de las empresas (84130) / Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria

    ¿Dónde se encuentra SKILLSMART RETAIL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Enterprise House 21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SKILLSMART RETAIL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SKILLSMART RETAIL UK LIMITED25 may 200425 may 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SKILLSMART RETAIL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SKILLSMART RETAIL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 93 Newman Street London W1T 3EZ el 25 ene 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 15 ene 2013

    LRESSP

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Ramesh Jetha Shingadia como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Stephen Hooper como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Louise Masson como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephanie Rice como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jacqui Humphries como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Patricia Doreen Deeny como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Samuel Houston Davidson como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Bell como director el 25 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicola Jane Zamblera como director el 30 sept 2012

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Ms Anne Seaman el 01 dic 2011

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 25 may 2012, aucune liste de membres fournie

    9 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ms Anne Seaman el 01 dic 2011

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Thomas Luke Ironside como director el 21 may 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher Stephen Hooper como director el 18 ene 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Samuel Houston Davidson como director el 18 ene 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Miss Louise Masson como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 25 may 2011, aucune liste de membres fournie

    8 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ms Patricia Doreen Deeny el 16 mar 2011

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de SKILLSMART RETAIL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TARR, Simon Charles Vaughan
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    Secretario
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    157201200001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    Director
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    United KingdomBritishNon Executive Director10084840001
    DAVIS, Steven James
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    Director
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    United KingdomBritishRetail Executive131311030001
    MURPHY, Rebecca Henrietta
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    Director
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    EnglandBritishHr And Marketing Director107609810001
    ROWLATT, Richard David
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    Director
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    EnglandBritishRetail Company Director28626440003
    SEAMAN, Anne
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    Director
    Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House 21
    United KingdomBritishDirector110436750002
    BROOME, Nigel Stuart
    Whinfield
    School Road
    BR7 5PQ Chislehurst
    Kent
    Secretario
    Whinfield
    School Road
    BR7 5PQ Chislehurst
    Kent
    British29905480003
    CHESHIRE, Ian Michael, Sir
    103 Balham Park Road
    SW12 8EB London
    Secretario
    103 Balham Park Road
    SW12 8EB London
    BritishCompany Director7668420002
    ILLINGWORTH, Michael David Holden
    36 Ormiston Grove
    W12 0JT London
    Secretario
    36 Ormiston Grove
    W12 0JT London
    BritishChartered Accountant105569140001
    KANJI, Sabira Mohamed
    52 Manor Way
    HA2 6BY Harrow
    Middlesex
    Secretario
    52 Manor Way
    HA2 6BY Harrow
    Middlesex
    British,KenyanAccountant59764140001
    TARR, Simon Charles Vaughan
    49 Weybridge Park
    KT13 8SQ Weybridge
    Surrey
    Secretario
    49 Weybridge Park
    KT13 8SQ Weybridge
    Surrey
    BritishChartered Accountant70803900002
    WILSON, John Charles
    60 Lavington Road
    Ealing
    W13 9LS London
    Secretario
    60 Lavington Road
    Ealing
    W13 9LS London
    BritishFinance Director127749720001
    BELL, Elizabeth
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    United KingdomBritishHr Director74505610001
    BIRD, Jemima Chloe
    Holland Park Gardens
    W14 8DZ London
    17a
    Director
    Holland Park Gardens
    W14 8DZ London
    17a
    United KingdomBritishMarketing Director135893870001
    BROOME, Nigel Stuart
    Whinfield
    School Road
    BR7 5PQ Chislehurst
    Kent
    Director
    Whinfield
    School Road
    BR7 5PQ Chislehurst
    Kent
    BritishChief Executive29905480003
    CHAPMAN, Clare Moira
    Paper Mill House
    Paper Mill Lane
    SG11 1LD Standon Ware
    Hertfordshire
    Director
    Paper Mill House
    Paper Mill Lane
    SG11 1LD Standon Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Personnel Director65688990001
    CHESHIRE, Ian Michael, Sir
    103 Balham Park Road
    SW12 8EB London
    Director
    103 Balham Park Road
    SW12 8EB London
    EnglandBritishCompany Director7668420002
    COLLINS, Robert Andrew
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    EnglandBritishRetailer206777980001
    DAVIDSON, Samuel Houston
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Northern IrelandBritishGroup Human Resources Director144864170001
    DEENY, Patricia Doreen
    Newman Street
    W1T 3EZ London
    93
    Director
    Newman Street
    W1T 3EZ London
    93
    United KingdomBritishHead Of Education158587010001
    DRUMMOND, Robert Gordon
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    ScotlandBritishNone116114980001
    HANNETT, John
    20 Hillfoot Road
    Wollton
    L25 0NB Liverpool
    Director
    20 Hillfoot Road
    Wollton
    L25 0NB Liverpool
    EnglandBritishGeneral Secretary Usdaw98867660001
    HAWKINS, Kevin
    3 Cedar Drive
    Flowers Hill
    RG8 7BH Pangbourne
    Berkshire
    Director
    3 Cedar Drive
    Flowers Hill
    RG8 7BH Pangbourne
    Berkshire
    BritishDirector General98136030001
    HOOPER, Christopher Stephen
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    EnglandBritishRetail Manager167419170001
    HUMPHRIES, Jacqui
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    United KingdomBritishHr Director158471140001
    ILLINGWORTH, Michael David Holden
    36 Ormiston Grove
    W12 0JT London
    Director
    36 Ormiston Grove
    W12 0JT London
    EnglandBritishChartered Accountant105569140001
    IRONSIDE, Thomas Luke
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    United KingdomBritishPolicy Director158471420001
    KELLY, Tessa Leueen Anne
    18a Laurel Road
    SW20 0PR London
    Director
    18a Laurel Road
    SW20 0PR London
    United KingdomBritishDirector72581930001
    KERR, Christine Gwenneth Danzey
    23 Stephenson Terrace
    NE41 8DZ Wylam
    Northumberland
    Director
    23 Stephenson Terrace
    NE41 8DZ Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritishMail Order Retail Womens Cloth22488770001
    LOVERING, John David
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    Director
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director73573160002
    MACKENZIE, John Kenneth
    37 Newton Grove
    Newton Mearns
    G77 5BX Glasgow
    East Nrewfrewshire
    Director
    37 Newton Grove
    Newton Mearns
    G77 5BX Glasgow
    East Nrewfrewshire
    BritishChief Officer83787030001
    MAGINN, Cecilia Jean
    12 Pineview Heights
    Gilford
    BT63 6AX Craigavon
    County Armagh
    Director
    12 Pineview Heights
    Gilford
    BT63 6AX Craigavon
    County Armagh
    BritishRetailer122647850001
    MAGINN, Cecilia Jean
    12 Pineview Heights
    Gilford
    BT63 6AX Craigavon
    County Armagh
    Director
    12 Pineview Heights
    Gilford
    BT63 6AX Craigavon
    County Armagh
    BritishRetailer122647850001
    MARCHANT, Philip William
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    UkBritishDirector3089830010
    MASSON, Louise
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    Director
    93 Newman Street
    London
    W1T 3EZ
    ScotlandBritishGeneral Manager162568180001

    ¿Tiene SKILLSMART RETAIL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent and service charge deposit deed
    Creado el 06 ago 2007
    Entregado el 16 ago 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    The deposit sum being £56,106.25 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £56,106.25 together with all interest accrued thereto.
    Personas con derecho
    • Lazari Gp Limited and Lazari Real Estates Limited
    Transacciones
    • 16 ago 2007Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene SKILLSMART RETAIL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 ene 2013Inicio de la liquidación
    19 feb 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Alfred George Alexander
    61 Prescot Street
    E1 8NN London
    Profesional
    61 Prescot Street
    E1 8NN London
    John Anthony Dickinson
    Carter Backer Winter Llp Enterprise House
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Profesional
    Carter Backer Winter Llp Enterprise House
    21 Buckle Street
    E1 8NN London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0