BRAND NEW CO (225) LIMITED

BRAND NEW CO (225) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRAND NEW CO (225) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05137991
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    • Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7 St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BARDSLEY LIMITED12 ago 200512 ago 2005
    BRAND NEW CO (225) LIMITED26 may 200426 may 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    16 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 abr 2020

    14 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 abr 2019

    16 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 abr 2018

    17 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Globe Square Dukinfield Cheshire SK16 4RG a 7 st. Petersgate Stockport Cheshire SK1 1EB el 11 may 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 26 abr 2017

    LRESEX

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    5 páginas4.20

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name09 sept 2016

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 20 jul 2016

    RES15

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 jun 2016

    Estado de capital el 20 jun 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    15 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2014 au 30 jun 2015

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 jun 2015

    Estado de capital el 16 jun 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de Graeme Spencer como director el 30 jun 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 jun 2014

    Estado de capital el 13 jun 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Graeme Spencer el 26 may 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Roland Bardsley el 26 may 2014

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Robert Edmund Paul Bodnar-Horvath como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Neil Macdougal como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARDSLEY, Roland
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Director
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    United KingdomBritish140518810002
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Director
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    EnglandBritish46232460002
    RAFTERY, Paul Matthew
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    Secretario
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    British62586740002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Secretario
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    British163442060001
    MACDOUGAL, Neil Charles
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    Director
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish93401120003
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Director
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish107908930001
    PURKIS, Stephen Robert
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Director
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish135467600002
    SPENCER, Graeme
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Director
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish140712180002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Director
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    United KingdomBritish163442060001
    THOMPSON, Alan Christopher
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    Director
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    United KingdomBritish39558890001

    ¿Tiene BRAND NEW CO (225) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 05 may 2011
    Entregado el 11 may 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 11 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    Blocked account charge
    Creado el 08 abr 2010
    Entregado el 15 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit being all or any of the amounts of the blocked account charge numbered 39139336 with sort code 01-05-31 see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 27 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 23 nov 2007
    Entregado el 28 nov 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings lying to the south side of worsley road worsley manchester (t/no GM138828) and all that land shown edged red on plan 2 annexed to the deed and all that land shown edged red on plan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 nov 2007Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 11 jul 2006
    Entregado el 19 jul 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h land on the east side of mottram old road stalybridge t/n GM118130,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jul 2006Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 17 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM952048 and all that f/h land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM945234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 10 nov 2004
    Entregado el 15 nov 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 2004Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene BRAND NEW CO (225) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 oct 2021Fecha prevista de disolución
    26 abr 2017Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Vincent Andrew Simmons
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    Profesional
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0