MAYFAIR GAMING LIMITED

MAYFAIR GAMING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMAYFAIR GAMING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05140722
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MAYFAIR GAMING LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra MAYFAIR GAMING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Seebeck House 1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MAYFAIR GAMING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DABBER LIMITED15 jun 200415 jun 2004
    PINCO 2138 LIMITED28 may 200428 may 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MAYFAIR GAMING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MAYFAIR GAMING LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MAYFAIR GAMING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 jul 2013

    Estado de capital el 23 jul 2013

    • Capital: GBP 64,654.4
    SH01

    Cese del nombramiento de Kevin Hamilton como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Andrew James Hall como director

    2 páginasAP01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 dic 2011

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * 17a Market Place Loughborough Leicestershire LE11 3EA* el 06 mar 2012

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Mr Kevin Hamilton el 01 nov 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Byron Evans como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Matthew Proctor como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Matthew Proctor como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O C/O Emw Picton Howell Llp Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR United Kingdom

    1 páginasAD02

    Cese del nombramiento de Brian Mattingley como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2009

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Emw Secretaries Limited como secretario

    2 páginasAP04

    ¿Quiénes son los directivos de MAYFAIR GAMING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EMW SECRETARIES LIMITED
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Secretario corporativo
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3512570
    93910510003
    EVANS, Byron
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglish140884750001
    HALL, Andrew James
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish150860820001
    MATTINGLEY, Brian
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    Secretario
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    150195100001
    MURRAY, Stephanie
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    Secretario
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    Australian123290920002
    PROCTOR, Matthew Frederick
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Secretario
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    151171890001
    VINER, Paul
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    Secretario
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    British117768960001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    DIXON, Gillian
    Croft House
    High Hesket
    CA4 0HS Carlisle
    Cumbria
    Director
    Croft House
    High Hesket
    CA4 0HS Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish146371490001
    FARRER-BROWN, Mark David
    Flat 15
    22 Brook Mews North
    W2 3BW London
    Director
    Flat 15
    22 Brook Mews North
    W2 3BW London
    EnglandBritish142028830001
    HAMILTON, Kevin
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147485660001
    HANNAH, Simon
    35 Turgis Road
    GU51 1EL Fleet
    Hampshire
    Director
    35 Turgis Road
    GU51 1EL Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish98633850001
    JEPP, Mark
    67 Humber Street
    DE65 5NW Hilton
    Derbyshire
    Director
    67 Humber Street
    DE65 5NW Hilton
    Derbyshire
    EnglandBritish184171270001
    JOHNSON, Luke
    32 Clarendon Gardens
    W9 1AZ London
    Director
    32 Clarendon Gardens
    W9 1AZ London
    EnglandBritish141745230001
    MATTINGLEY, Brian Roger
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    Director
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    United KingdomBritish22417130002
    MAY, Paul Edward
    The Old Rectory
    Bradden
    NN12 8ED Towcester
    Northamptonshire
    Director
    The Old Rectory
    Bradden
    NN12 8ED Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish83046570001
    MURRAY, Stephanie
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    Director
    Market Place
    LE11 3EA Loughborough
    17a
    Leicestershire
    EnglandAustralian123290920002
    PROCTOR, Matthew Frederick
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Director
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish136671560001
    VINER, Paul
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    Director
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    British117768960001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Director corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    ¿Tiene MAYFAIR GAMING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 20 abr 2010
    Entregado el 27 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company, each borrower, each obligor and each chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 10 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 11 ago 2006
    Entregado el 18 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H heaton bingo and social club, heaton assembly buildings, heaton road, newcastle-upon-tyne t/nos ty 400329 and nd 2002; l/h pasdena bingo club, lowtown, pudsey, leeds t/no WYK790515; l/h riva bingo club, 2ND floor, castlegate leisure centre, lombard street, newark, nottinghamshire t/no nt 409117 (for details of further property charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 10 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 jun 2005
    Entregado el 24 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Luke Johnson
    Transacciones
    • 24 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creado el 09 sept 2004
    Entregado el 14 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy being, policy number: ah/300002/04/01 taken out by the company with universal accident & health over the life of mr simon hannah.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 14 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 jun 2004
    Entregado el 30 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Luke Johnson (The Security Agent)
    Transacciones
    • 30 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 jun 2004
    Entregado el 25 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0