POULTER MARKETING GROUP LIMITED

POULTER MARKETING GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPOULTER MARKETING GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05188168
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Rose Wharf
    East Street
    LS9 8EE Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INHOCO 3106 LIMITED23 jul 200423 jul 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    5 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 23 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ago 2011

    Estado de capital el 08 ago 2011

    • Capital: GBP 939,938
    SH01

    legacy

    18 páginasMG01

    Nombramiento de Mr Trevor John O'reilly como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gary Knights como director

    1 páginasTM01

    legacy

    18 páginasMG01

    Cese del nombramiento de Mark Shaw como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Richard Timothy Barfield como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Timothy Barfield como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Mark Shaw como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 23 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2009

    8 páginasAA

    legacy

    15 páginasMG01

    Cese del nombramiento de William Ronald como director

    1 páginasTM01

    legacy

    7 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    157835390001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish123477010001
    O'REILLY, Trevor John
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    Director
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    IrelandIrish148130760001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Secretario
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    British129305300001
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Secretario
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    British105115960001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Secretario
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British103609160001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Secretario
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    British107353690001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BUCKLE, Mark Raymond
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish121880340001
    COLTON HAWKINS, Darren John
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    British100773780001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Director
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    EnglandBritish129305300001
    GORING, Nicholas Francis
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    Director
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish100773750001
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    Director
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritish45695650002
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Director
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    United KingdomBritish105115960001
    MCCALL, Gary William
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Director
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish59547330001
    RIVETT JONES, Peter
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish112998390001
    RONALD, William David Gordon
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    Director
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritish138299060001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Director
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish103609160001
    SAXBY, Mark Kenneth Baber
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    Director
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish59543920002
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Director
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107353690001
    TOYNTON, Peter Anthony
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    Director
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    United KingdomBritish9723050002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Director designado corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    PEMBRIDGE PARTNERS LLP
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Director corporativo
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    85753460001

    ¿Tiene POULTER MARKETING GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security confirmation and supplemental deed
    Creado el 13 jun 2011
    Entregado el 17 jun 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    A security confirmation and supplemental deed
    Creado el 24 feb 2011
    Entregado el 08 mar 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Charged by way of fixed charge all shares all related distribution rights all investment and all related distribution rights all book debts and all benefits rights and security held in respect of or to secure the payment of the book debts see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transacciones
    • 08 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    A confirmatory deed
    Creado el 18 dic 2009
    Entregado el 04 ene 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 04 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    A confirmatory deed
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 14 ago 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 ago 2009Registro de un cargo (395)
    Confirmatory deed supplemental to a debenture originally dated 19 august 2005 and
    Creado el 17 mar 2009
    Entregado el 25 mar 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 mar 2009Registro de un cargo (395)
    Supplemental deed
    Creado el 20 mar 2008
    Entregado el 10 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 abr 2008Registro de un cargo (395)
    Security accession deed
    Creado el 15 sept 2006
    Entregado el 27 sept 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustees for the Finance Parties
    Transacciones
    • 27 sept 2006Registro de un cargo (395)
    Guarantee & debenture
    Creado el 04 oct 2004
    Entregado el 16 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the holders of the loan stock 2006 or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Murray Johnstone Limited (Security Trustee as Trustee for Each of the Holders of the Loan Stock)
    Transacciones
    • 16 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 oct 2004
    Entregado el 12 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0