ASCRIBE HOLDINGS LIMITED

ASCRIBE HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASCRIBE HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05204003
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Fulford Grange Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ASCRIBE HOLDINGS PLC20 feb 200920 feb 2009
    ASCRIBE PLC25 nov 200425 nov 2004
    ASCRIBE LIMITED19 nov 200419 nov 2004
    EVER 2458 LIMITED12 ago 200412 ago 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Estado de capital el 10 oct 2022

    • Capital: GBP 0.01
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 24/08/2022
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    Capitalise £6190104 23/08/2022
    RES14

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 23/08/2022
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 ago 2022

    • Capital: GBP 7,407,275.61
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 12 ago 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 ago 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England a Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 páginasAD04

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 páginasAD04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 ago 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Scroll Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov 2019

    2 páginasPSC05

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA

    1 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Rawdon House Green Lane Yeadon Leeds LS19 7BY a Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA el 02 dic 2019

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BENSON, Christine
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Secretario
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    239348480001
    SOUTHBY, Peter John
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Director
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish116859780002
    STEWART, Paul
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Director
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish262072580001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Secretario
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    192309700001
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Secretario
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    British98814590001
    MOTTRAM, Mandy Joanne
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    Secretario
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    166860890001
    WAITE, Simon Nicholas
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    Secretario
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    213729210001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secretario designado corporativo
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    BARBER, Dean Anthony
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    Director
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    EnglandBritish230739040001
    CRITCHLOW, Anthony Stephen
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    Director
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    EnglandBritish101716720002
    DICKSON, Christopher John
    Upton Grange
    Wonston
    SO21 3LR Winchester
    Director
    Upton Grange
    Wonston
    SO21 3LR Winchester
    EnglandBritish100748280003
    HUGHES, David Michael
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    Director
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    EnglandBritish12292930002
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Director
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    United KingdomBritish98814590001
    LEWIS, Graham Robert
    32 Ernest Road
    Wivenhoe
    CO7 9LQ Colchester
    Essex
    Director
    32 Ernest Road
    Wivenhoe
    CO7 9LQ Colchester
    Essex
    British117396680001
    MOORE, Christopher Edward
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish34428100003
    PRIESTNER, Ian
    Tirley Cottage
    Tirley Lane, Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Director
    Tirley Cottage
    Tirley Lane, Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish114678190001
    SPENCER, Christopher Michael Kennedy
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Director
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish4742550002
    TAMBLYN, Christina
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Director
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish191028210001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    Ascribe House
    Branker Street Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Director
    Ascribe House
    Branker Street Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    EnglandBritish154577090001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Director
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    British74738270002
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Director designado corporativo
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    06 abr 2016
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalUk
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06724468
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene ASCRIBE HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 26 mar 2009
    Entregado el 01 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Eci Ventures Nominees Limited
    Transacciones
    • 01 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 26 mar 2009
    Entregado el 01 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage over stocks and shares by owner to secure own account
    Creado el 26 mar 2009
    Entregado el 01 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The stocks shares and other marketable securities being 1 arkive computing limited (company number 4611493) ordinary, 292,886,176 ascribe limited (formerly known as asc computer software limited (company number 2394847) ordinary, 100 barwick systems limited (company number 1756830) ordinary see image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment of contracts
    Creado el 10 may 2006
    Entregado el 27 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the rights and powers under the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 mar 2006
    Entregado el 17 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0