CARDSAVE HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARDSAVE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05207657 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Parkway Offices Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby South Humberside |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BROOMCO (3521) LIMITED | 17 ago 2004 | 17 ago 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2015 au 31 ene 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kevin Patrick O'keefe como director el 14 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Joanna Mary Baker como director el 14 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Stephen Wilson como director el 14 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Frank Paul Christian D'hollander como director el 12 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Mark Dann como director el 31 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Mark Dann como secretario el 31 dic 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony Mark Dann el 17 oct 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Anthony Mark Dann el 17 oct 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Clive Kahn como director el 01 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 55 Mansell Street London E1 8AN a Walbrook Building Walbrook London EC4N 8AF | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Aidan Connolly como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ron Kalifa como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Frank D'hollander como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Arthur Hobday como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Stephen Wilson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Darren Wilson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, Joanna Mary | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | England | British | 248233600001 | |||||
| HOBDAY, David Arthur | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | England | British | 186436550001 | |||||
| O'KEEFE, Kevin Patrick | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | England | American | 203583750001 | |||||
| DANN, Anthony Mark | Secretario | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | British | 96438940006 | ||||||
| POPPLETON, Gareth David | Secretario | The Cottage Conisholme Road North Somercotes LN11 7PS Louth Lincolnshire | British | 57603080001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BENTHAM, Paul Gerald | Director | Villa Franove, 43 Avenue Des Bosquets-De-Julie Clarens Montreux 1815 Switzerland | Switzerland | British | 103837360001 | |||||
| CONNOLLY, Aidan Joseph | Director | 55 Mansell Street E1 8AN London Worldpay England | England | British | 100376210001 | |||||
| D'HOLLANDER, Frank Paul Christian | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | Belgium | Belgian | 177967690001 | |||||
| DANN, Anthony Mark | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | United Kingdom | British | 96438940008 | |||||
| DILLON, John Eamon | Director | The Hey House Lapworth Street Lapworth B94 5QF Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 54871970006 | |||||
| HART, Stephen Andrew | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | Scotland | British | 157053520001 | |||||
| JOHNSON, Duncan Edward | Director | Baigens Winchester Road GU34 1SL Chawton Hampshire | United Kingdom | British | 266556880001 | |||||
| KAHN, Clive Ian | Director | 8 Turner Drive NW11 6TX London | England | British | 124009130001 | |||||
| KALIFA, Ron | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | United Kingdom | British | 106749110001 | |||||
| KANTER, Ralph Thomas Ludwig | Director | Garden Flat 17 Upper Park Road NW3 2UN London | United Kingdom | British | 124153720001 | |||||
| ORMONDE, James | Director | Brickyard Farm Rasen Rooad DN21 4RN Waddingham Lincolnshire | England | British | 163350780001 | |||||
| POPPLETON, Gareth David | Director | The Cottage Conisholme Road North Somercotes LN11 7PS Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | 57603080001 | |||||
| RIGGALL, Jonathan | Director | 2 Tennyson Street LE19 3FD Narborough Leicestershire | England | British | 103969910001 | |||||
| RYDER, Ian Bernard | Director | 45 Clematis Avenue Healing DN41 7JJ Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 84313960003 | |||||
| WILSON, Darren | Director | 55 Mansell Street E1 8AN London Worldpay England | England | British | 113021310001 | |||||
| WILSON, David Stephen | Director | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | England | British | 100909000001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardsave Acquisitions Limited | 06 abr 2016 | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene CARDSAVE HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 09 ago 2007 Entregado el 28 ago 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moniees due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 29 oct 2004 Entregado el 09 nov 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and to the security beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0