PRAX UPSTREAM LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PRAX UPSTREAM LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05245689 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PRAX UPSTREAM LIMITED?
- Extracción de petróleo crudo (06100) / Explotación de minas y canteras
- Extracción de gas natural (06200) / Explotación de minas y canteras
¿Dónde se encuentra PRAX UPSTREAM LIMITED?
| Dirección de la sede social | 4th Floor 72 Welbeck Street W1G 0AY London Greater London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PRAX UPSTREAM LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HURRICANE ENERGY LIMITED | 22 jun 2023 | 22 jun 2023 |
| HURRICANE ENERGY PLC | 17 abr 2013 | 17 abr 2013 |
| HURRICANE EXPLORATION PLC | 24 feb 2005 | 24 feb 2005 |
| HURRICANE EXPLORATION LIMITED | 22 dic 2004 | 22 dic 2004 |
| BLAKEDEW 531 LIMITED | 29 sept 2004 | 29 sept 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PRAX UPSTREAM LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 28 feb 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 28 feb 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 29 feb 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PRAX UPSTREAM LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRAX UPSTREAM LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro de la carga 052456890008, creada el 12 feb 2026 | 35 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 052456890007, creada el 22 dic 2025 | 35 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elemental Company Secretarial Limited como secretario el 11 dic 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas John Pike como director el 11 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alessandro Agostini como director el 11 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Amba Secretaries Limited como secretario el 11 dic 2025 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Iain Charles Mckendrick como director el 11 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen David Lambert como director el 11 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Charles Fewkes como director el 11 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 4th Floor 72 Welbeck Street Paddington Central, Kingdom Street London Greater London W1G 0AY United Kingdom a 4th Floor 72 Welbeck Street London Greater London W1G 0AY el 11 dic 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Paul Killeen como director el 11 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Martin Cox como director el 11 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Martin Francis David Copeland como director el 11 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Harvest House Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ United Kingdom a 4th Floor 72 Welbeck Street Paddington Central, Kingdom Street London Greater London W1G 0AY el 11 dic 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date | 3 páginas | RP01CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Nicholas John Pike el 22 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Nicholas John Pike como director el 06 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Winston Sanjeevkumar Soosaipillai como director el 04 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 29 feb 2024 | 60 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2023 au 28 feb 2024 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 116 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed hurricane energy LIMITED\certificate issued on 23/06/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PRAX UPSTREAM LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBA SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 72 Welbeck Street Paddington Central, Kingdom Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London United Kingdom |
| 115238010001 | ||||||||||
| COPELAND, Martin Francis David | Director | 72 Welbeck Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London England | England | British | 140268250001 | |||||||||
| COX, Christopher Martin | Director | 72 Welbeck Street Paddington Central, Kingdom Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London United Kingdom | England | British | 115341280003 | |||||||||
| FEWKES, Daniel Charles | Director | 72 Welbeck Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London England | England | British | 197640080001 | |||||||||
| KILLEEN, Michael Paul | Director | 72 Welbeck Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London England | Scotland | British | 303105930001 | |||||||||
| LAMBERT, Stephen David | Director | 72 Welbeck Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London England | England | British | 207622530001 | |||||||||
| CHAFFE, Richard Paul | Secretario | Horizon Business Village 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge Harvest House Surrey United Kingdom | 295364170001 | |||||||||||
| JANKES, Daniel | Secretario | Abbey Mill Business Park GU7 2QN Lower Eashing Ground Floor The Wharf Surrey England | British | 163619260001 | ||||||||||
| BLAKELAW SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 38915800008 | |||||||||||
| BREAMS REGISTRARS AND NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | 52 Bedford Row WC1R 4LR London | 900002310001 | |||||||||||
| ELEMENTAL COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 England |
| 310044330001 | ||||||||||
| AGOSTINI, Alessandro | Director | 72 Welbeck Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London England | United Kingdom | British,Italian | 306719990001 | |||||||||
| ALLAN, Robert Andrew | Director | Horizon Business Village 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge Harvest House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 173055720001 | |||||||||
| ARNOTT, Robert John | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | England | British | 181229190001 | |||||||||
| BEAL, Linda Janice | Director | Horizon Business Village 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge Harvest House Surrey United Kingdom | England | British | 296261060001 | |||||||||
| BRIGGS, Nicholas Howard | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | England | British | 64953680004 | |||||||||
| CHAFFE, Richard Paul | Director | Horizon Business Village 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge Harvest House Surrey United Kingdom | England | British | 270532520001 | |||||||||
| CHENG, Jason Aun Minn | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | Hong Kong | Australian | 223698720002 | |||||||||
| CRAIK, David Ian | Director | Horizon Business Village 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge Harvest House Surrey United Kingdom | England | British | 7978320001 | |||||||||
| DAYER, Philip John | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | England | British | 157539810001 | |||||||||
| GOOD, Charles Anthony | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | England | British | 6848410005 | |||||||||
| GUEST, William James | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | British | 131051030001 | ||||||||||
| HARVEY, Russell Seth | Director | Hunters Croft Grayswood GU27 Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 23757260001 | |||||||||
| HEANEY, Robert Charles | Director | Valais Les Grands Vaux JE2 7NA St Helier Channel Islands | British | 117757070001 | ||||||||||
| HOGAN, John Anthony | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | United Kingdom | British | 94257040001 | |||||||||
| HUDDLESTON, James Wallace | Director | Suite, 7th Floor, Building 170, Road 1703, Block 317 Manama Bahrain | British | 105293960001 | ||||||||||
| JENKINS, David Anthony Lawson, Dr. | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | United Kingdom | British | 813330001 | |||||||||
| KELLY, Roy Thomas | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | England | British | 207980930001 | |||||||||
| KIRBY, Keith | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | United Kingdom | British | 162174610001 | |||||||||
| MARDON TAYLOR, Nicholas John | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | England | British | 105294260003 | |||||||||
| MARDON TAYLOR, Nicholas John | Director | 52 Bedford Row London WC1R 4LR | England | British | 105294260003 | |||||||||
| MARIS, Antony Wayne | Director | Horizon Business Village 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge Harvest House Surrey United Kingdom | England | British | 78957850001 | |||||||||
| MCKENDRICK, Iain Charles | Director | 72 Welbeck Street W1G 0AY London 4th Floor Greater London England | Scotland | British | 272476200001 | |||||||||
| MCTIERNAN, Steven James | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | England | British | 245906980001 | |||||||||
| MONTAGUE, Adrian Alastair, Sir | Director | Abbey Mill Business Park Lower Eashing GU7 2QN Godalming Ground Floor The Wharf Surrey | United Kingdom | British | 162195170001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PRAX UPSTREAM LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 24 jul 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0