GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05296748 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Fleet Place EC4M 7QS London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elena Giorgiana Wegener como director el 07 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 dic 2021 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH a 10 Fleet Place London EC4M 7QS el 17 ene 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Renuncia de un liquidador | 3 páginas | LIQ06 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 42 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 dic 2020 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 dic 2019 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jordan Company Secretaries Limited como secretario el 28 feb 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL United Kingdom a One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH el 16 ene 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Alan Quaife como director el 12 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Christopher Heath como director el 12 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Evariste Poissot Iii como director el 01 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Jordan Company Secretaries Limited el 16 ago 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 21 st Thomas Street Bristol BS1 6JS a First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL el 31 jul 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 nov 2016 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 29 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSTEIN, Aaron Gerard | Director | 100 Fluor Daniel Drive Greenville Fluor Enterprises Inc Sc 29607 United States | United States | American | 178871350001 | |||||||||
| HEATH, James Christopher | Director | SW1Y 4QU London 12 Charles Ii Street United Kingdom | United Kingdom | British | 122413700002 | |||||||||
| LAMBERT, David Maurice | Director | Latimer Road Wimbledon SW19 1EW London 67 England England | United Kingdom | British | 105128280001 | |||||||||
| MASON, Graham Melville | Director | 140 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Fluor Centre Hampshire United Kingdom | England | British | 153921440001 | |||||||||
| JENKINSON, Louisa Jane | Secretario | Lindenwood Malacca Farm GU4 7UG West Clandon Surrey | British | 106060330003 | ||||||||||
| LYON, Karen | Secretario | Belvedere Court 372-374 Upper Richmond Road SW15 6HY London 33 United Kingdom | Other | 140536930001 | ||||||||||
| MCKEE, Michael Joseph | Secretario | 38 Cavendish Road EN5 4DZ Barnet Hertfordshire | United States | 76245690001 | ||||||||||
| MILLER, Philip | Secretario | Sutton Court Fauconberg Road W4 3JF London 87 | Other | 128209650001 | ||||||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
| 97584300001 | ||||||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Secretario corporativo | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||||||
| AMPARANO, Gregory Jude | Director | Weldon Heights Ladera Ranch CA 92694 8 California United States | United States | 111854320002 | ||||||||||
| CHALKLEY, Martyn | Director | Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough 140 Hampshire | United Kingdom | British | 163271330001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 116775310001 | |||||||||
| DAVISON, Ronald | Director | Apartment 41 Chelsea Gate Apartments, 93 Ebury Bridge Road SW1W 8RB London | Australian | 113688230001 | ||||||||||
| DEDIEU, Michael | Director | St George's Court Gloucester Road SW7 4RA London Flat 47 United Kingdom | United Kingdom | French | 152210870001 | |||||||||
| FLAHERTY, Patrick Paul | Director | Rose Of Tralee Reading Road RG27 9EB Hook Hampshire | United Kingdom | British | 64396600002 | |||||||||
| GARNER, David | Director | 140 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Fluor Centre Hampshire Uk | United Kingdom | British | 161673340001 | |||||||||
| ILLMAN, Stephen Mark | Director | Ridgeway , Quinton Business Park Quinton B32 1AF Birmingham 9 United Kingdom | British | 132427230001 | ||||||||||
| JONES, Bryn David Murray | Director | Westwood St Dunstan West Street TN4 8XT Mayfield East Sussex | United Kingdom | British | 123252980001 | |||||||||
| MCKEE, Michael Joseph | Director | 38 Cavendish Road EN5 4DZ Barnet Hertfordshire | United Kingdom | United States | 76245690001 | |||||||||
| POISSOT III, Evariste | Director | Ridgeway Quinton B32 1AF Birmingham 9 United Kingdom | Usa | American | 178877510001 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||||||
| WEGENER, Elena Giorgiana | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | England | British | 183219270001 | |||||||||
| WOODHAMS, Mark Richard | Director | Bracken Hill Maidstone Road, St Marys Platt TN15 8JH Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 76838370001 | |||||||||
| SLC CORPORATE SERVICES LIMITED | Director corporativo | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 74654310001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrared Infrastructure Yield Holdings Limited | 06 abr 2016 | SW1Y 4QU London 12 Charles Ii Street | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Fluor International Limited | 06 abr 2016 | Watchmoor Park Riverside Way SGU15 3YL Camberley Fluor Centre Surrey | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Creado el 16 sept 2005 Entregado el 06 oct 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any finance party or to any junior creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene GENESYS TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0