PBS HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPBS HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05297966
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PBS HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de sociedades holding de servicios financieros (64205) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra PBS HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Brookfield Court Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PBS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 mar 2022

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PBS HOLDINGS LIMITED?

    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta09 sept 2023

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PBS HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 mar 2023 au 29 sept 2023

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2023 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 mar 2022

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mr Shane O’Neill como director el 24 oct 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy John Smyth como director el 24 oct 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Penelope Jane Fullerton como secretario el 24 oct 2022

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a Brookfield Court Selby Road Garforth Leeds LS25 1NB el 26 sept 2022

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 mar 2021

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Elizabeth Anne Brophy como secretario el 31 may 2022

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Penelope Jane Fullerton como secretario el 01 jun 2022

    2 páginasAP03

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2021 au 30 mar 2021

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG el 17 ago 2020

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG el 17 ago 2020

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de The Hamlet Hornbeam Park Harrogate HG2 8RE England a 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG el 03 ago 2020

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Richard Miles Skingle como director el 27 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    19 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PBS HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    O’NEILL, Shane
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    Director
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    EnglandIrish301599440001
    BLOTT, Stephen
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    Secretario
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    British139352410001
    BROPHY, Elizabeth Anne
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    Secretario
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    247170400001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Beck Road
    BD16 3JN Bingley
    Holroyd House
    England
    Secretario
    Beck Road
    BD16 3JN Bingley
    Holroyd House
    England
    296527630001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Secretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    184072210001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Secretario
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Secretario
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    ORTON, Jeffrey Christopher
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Secretario
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    185574260001
    ZACZKIEWICZ, Stacey
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Secretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    170327450001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    Secretario corporativo
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    37896530011
    ALEXANDER, Laura Catherine Elizabeth
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish268740360001
    AMISS, Michael Hamilton
    207 Key Palm Road
    Boca Raton
    Florida 33432
    Usa
    Director
    207 Key Palm Road
    Boca Raton
    Florida 33432
    Usa
    British100929450001
    BARCLAY, Ian James
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish184779440002
    BEALES, Karen Anne
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    Director
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    EnglandBritish135540180002
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40471660002
    DAVEY, Jonathan Mark
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    Director
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    EnglandBritish81484820003
    GILL, Ryan Mark
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish184068890001
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Director
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    British79523100001
    HUBBARD, Peter John
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish28375870003
    JEWELL, Paul John
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Director
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    EnglandBritish221544490001
    KEATING, Michael Samuel
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish135065160001
    LAIRD, Oliver Walter
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritish233726140001
    LEIGHTON, Maria Louise
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish202291580001
    MARLEY, Nicholas James
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    Director
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    United KingdomBritish113304050001
    NATHAN, Clive Adam
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish207013760001
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Director
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritish139631580001
    ROLFE, Timothy Paul
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    Director
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish107872640001
    ROUSE, Jonathan Edward
    10 Osprey House
    5 Victory Place Northey Street
    E14 8BG London
    Director
    10 Osprey House
    5 Victory Place Northey Street
    E14 8BG London
    United KingdomBritish99883240002
    SAGGU, Ranvir Singh
    21 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    Director
    21 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    EnglandBritish115958310001
    SKINGLE, Richard Miles
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Director
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    EnglandBritish203052180001
    SMITH, Malachy Paul
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    IrelandIrish262619320001
    SMYTH, Timothy John
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    Director
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    EnglandBritish77794000006
    SMYTH, Timothy John
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    Director
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish77794000002
    WARREN, Michael Ian
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    EnglandBritish140310390001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PBS HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Rural & Commercial Holdings Limited
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    06 abr 2016
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Uk Limited Companies
    Número de registro09248435
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0