PBS HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PBS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05297966 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PBS HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de sociedades holding de servicios financieros (64205) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra PBS HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Brookfield Court Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PBS HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 mar 2022 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PBS HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 sept 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PBS HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 mar 2023 au 29 sept 2023 | 1 páginas | AA01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 mar 2022 | 21 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Shane O’Neill como director el 24 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy John Smyth como director el 24 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Penelope Jane Fullerton como secretario el 24 oct 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a Brookfield Court Selby Road Garforth Leeds LS25 1NB el 26 sept 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 mar 2021 | 21 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Elizabeth Anne Brophy como secretario el 31 may 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mrs Penelope Jane Fullerton como secretario el 01 jun 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2021 au 30 mar 2021 | 1 páginas | AA01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG el 17 ago 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG el 17 ago 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Hamlet Hornbeam Park Harrogate HG2 8RE England a 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG el 03 ago 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Miles Skingle como director el 27 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 19 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de PBS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O’NEILL, Shane | Director | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | Irish | 301599440001 | |||||
| BLOTT, Stephen | Secretario | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| BROPHY, Elizabeth Anne | Secretario | Selby Road Swillington Common LS15 4LG Leeds 3.1 Carrwood Park West Yorkshire England | 247170400001 | |||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Secretario | Beck Road BD16 3JN Bingley Holroyd House England | 296527630001 | |||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Secretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184072210001 | |||||||
| KEILL, Tracy Elizabeth | Secretario | 'Verandah House' 8 Pokiok Road Smith's Fl05 Bermuda | British | 127332980001 | ||||||
| MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Secretario | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | British | 75598460002 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Secretario | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | 185574260001 | |||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Secretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | 170327450001 | |||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | The Corn Exchange Baffins Lane PO19 1GE Chichester West Sussex | 37896530011 | |||||||
| ALEXANDER, Laura Catherine Elizabeth | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 268740360001 | |||||
| AMISS, Michael Hamilton | Director | 207 Key Palm Road Boca Raton Florida 33432 Usa | British | 100929450001 | ||||||
| BARCLAY, Ian James | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184779440002 | |||||
| BEALES, Karen Anne | Director | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | 135540180002 | |||||
| BRADBURY, Susan Patricia | Director | Causeway Foot Rochdale Road Pole Moor Outlane HD3 3FQ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 40471660002 | |||||
| DAVEY, Jonathan Mark | Director | 6 Mill Close Lane Patrick Brompton DL8 1AJ Bedale North Yorkshire | England | British | 81484820003 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184068890001 | |||||
| HODES, Jonathan | Director | 81 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London | British | 79523100001 | ||||||
| HUBBARD, Peter John | Director | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 28375870003 | |||||
| JEWELL, Paul John | Director | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | England | British | 221544490001 | |||||
| KEATING, Michael Samuel | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 135065160001 | |||||
| LAIRD, Oliver Walter | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 233726140001 | |||||
| LEIGHTON, Maria Louise | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 202291580001 | |||||
| MARLEY, Nicholas James | Director | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | 113304050001 | |||||
| NATHAN, Clive Adam | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 207013760001 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Director | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| ROLFE, Timothy Paul | Director | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | 107872640001 | |||||
| ROUSE, Jonathan Edward | Director | 10 Osprey House 5 Victory Place Northey Street E14 8BG London | United Kingdom | British | 99883240002 | |||||
| SAGGU, Ranvir Singh | Director | 21 Kearton Close CR8 5EN Kenley Surrey | England | British | 115958310001 | |||||
| SKINGLE, Richard Miles | Director | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | England | British | 203052180001 | |||||
| SMITH, Malachy Paul | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | Ireland | Irish | 262619320001 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Director | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | British | 77794000006 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Director | 2 Knoll Road RH4 3EW Dorking Surrey | United Kingdom | British | 77794000002 | |||||
| WARREN, Michael Ian | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | England | British | 140310390001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PBS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural & Commercial Holdings Limited | 06 abr 2016 | Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0