HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 05331020 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Dirección de la sede social | The Rees Centre Mudge Way PL7 2PS Plymouth United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HOME-START SOUTH HAMS, PLYMOUTH AND TAVISTOCK | 13 ene 2011 | 13 ene 2011 |
| HOME-START SOUTH HAMS | 12 ene 2005 | 12 ene 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 09 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 25 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Anne May-Somerville como director el 08 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 19 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Susan Jane Holdsworth como secretario el 15 abr 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Andrea Leza Chandler como secretario el 15 abr 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Bella Jewel Westlake como director el 16 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Helen Wilkinson como director el 26 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Sue Stiles como director el 26 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 15 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Lorraine Fletcher Obonyo como director el 02 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Barbara Watson como director el 02 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Harris como director el 13 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Sue Stiles como director el 20 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Helen Wilkinson como director el 20 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 19 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Bella Jewel Westlake como director el 06 feb 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Emma Gibson como director el 05 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 18 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Catherine Mary Stoate como director el 15 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 15 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Emma Gibson como director el 27 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDSWORTH, Susan Jane | Secretario | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | 334742410001 | |||||||
| FLETCHER OBONYO, Lorraine | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 329932030001 | |||||
| JONES, Diane | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 256054020001 | |||||
| MAY-SOMERVILLE, Anne | Director | Bere Ferrers PL20 7JF Yelverton Parsonage Farm Devon England | England | British | 340136320001 | |||||
| MONK, David Reginald | Director | North Upton Barns Bantham TQ7 3AB Nr Kingsbridge Butterwell South Devon England | England | English | 48853780001 | |||||
| TAYLER, Mary Alice | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 283281270001 | |||||
| WATSON, Barbara | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 329931660001 | |||||
| CHANDLER, Andrea Leza | Secretario | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | 245226840001 | |||||||
| CHAPMAN, Alan | Secretario | Hopeside South Milton TQ7 3JR Kingsbridge Devon | British | 102486070001 | ||||||
| BUTCHER, Joanne Lydia, Dr | Director | 163 Ridgeway Plympton PL7 2HJ Plymouth The Plympton Hub, Avon House Devon England | United Kingdom | British | 184414810001 | |||||
| BUTCHER, Joanne Lydia, Dr | Director | Ilbert Road TQ7 1DZ Kingsbridge Age Concern Building Devon United Kingdom | United Kingdom | British | 184414810001 | |||||
| CHAPMAN, Alan | Director | Hopeside South Milton TQ7 3JR Kingsbridge Devon | British | 102486070001 | ||||||
| CHAPMAN, Alan | Director | Hopeside South Milton TQ7 3JR Kingsbridge Devon | British | 102486070001 | ||||||
| CHAPMAN, Lynda Margaret | Director | Church Road Plymstock PL9 9AR Plymouth The Old Surgery England | England | British | 187268430001 | |||||
| COLLINS, Emma Louise | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 240133460001 | |||||
| CONWAY, Victoria Clare | Director | Woodland Road Harbertonford TQ9 7SX Totnes St Peters Court Devon | England | British | 146868200001 | |||||
| CURTIS, Elaine Nina | Director | Chilley Barns East Allington TQ9 7QN Totnes The Hay Barn Devon England | England | British | 139929580001 | |||||
| CURTIS, Elaine Nina | Director | Chilley Barns East Allington TQ9 7QN Totnes The Hay Barn Devon | England | British | 139929580001 | |||||
| CURTIS, Elaine Nina | Director | Chilley Barns East Allington TQ9 7QN Totnes The Hay Barn Devon | England | British | 139929580001 | |||||
| ELLIS, Nigel Richard | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 239203910001 | |||||
| GIBSON, Emma | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 287686340001 | |||||
| HARRIS, Stuart | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 266912900001 | |||||
| HEAVISIDES, Eric | Director | 3 Meadow Court Barns TQ7 2SU Stokenham Devon | United Kingdom | British | 119719620001 | |||||
| HEAVISIDES, Eric | Director | 3 Meadow Court Barns TQ7 2SU Stokenham Devon | United Kingdom | British | 119719620001 | |||||
| HENDERSON, Georgia Ruby | Director | 163 Ridgeway Plympton PL7 2HJ Plymouth The Plympton Hub, Avon House Devon England | Uk | British | 175449630001 | |||||
| JEROME, James Stephen | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 240133810001 | |||||
| MARKS, Barbara | Director | Young Families Office Age Concern Building Ilbert Road TQ7 1DZ Kingsbridge Devon | Uk | British | 159514910001 | |||||
| MAY, Shelagh Veronica | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 228993800001 | |||||
| MONK, David Reginald | Director | Butterwell North Upton Barns Bantham TQ7 3AB Kingsbridge Devon | England | English | 48853780001 | |||||
| MONK, David Reginald | Director | Butterwell North Upton Barns Bantham TQ7 3AB Kingsbridge Devon | England | English | 48853780001 | |||||
| SMITH, Mary Elisabeth | Director | 163 Ridgeway Plympton PL7 2HJ Plymouth The Plympton Hub, Avon House Devon England | England | British | 191934720001 | |||||
| STILES, Sue | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 316204600001 | |||||
| STOATE, Catherine Mary | Director | Mudge Way PL7 2PS Plymouth The Rees Centre United Kingdom | England | British | 184191870001 | |||||
| THOMPSON, David John | Director | Young Families Office Age Concern Building Ilbert Road TQ7 1DZ Kingsbridge Devon | England | British | 184414780001 | |||||
| THOMPSON, David John, Doctor | Director | Harberton TQ9 7SS Totnes Hallalen Devon Uk | Uk | British | 131143110001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mrs Joanna Lydia Butcher | 03 oct 2016 | 163 Ridgeway Plympton PL7 2HJ Plymouth The Plympton Hub, Avon House Devon | Sí |
Nacionalidad: Bristish País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para HOME-START SOUTH AND WEST DEVON LTD?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 25 jul 2018 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0