THREE COMPASSES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | THREE COMPASSES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05348152 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THREE COMPASSES LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra THREE COMPASSES LIMITED?
Dirección de la sede social | First Floor Kirkdale House Kirkdale Road E11 1HP Leytonstone London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THREE COMPASSES LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 ago 2013 |
Próximas cuentas vencen el | 31 may 2014 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THREE COMPASSES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Enamur Ur Rahman como director el 26 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Enamur Rahman como secretario el 26 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Trevor Keeble como director el 26 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Enamur Rahman el 31 oct 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Enamur Rahman el 31 oct 2013 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Henry Thomas Smith el 31 oct 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Enamur Rahman el 31 oct 2013 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Enamur Rahman el 31 oct 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr James Trevor Keeble el 31 oct 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr James Trevor Keeble el 15 nov 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Copper House Snakes Lane East Woodford Green Essex IG8 7HX United Kingdom* el 04 nov 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 ago 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Enamur Rahman el 03 may 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 31 ene 2013 | 18 páginas | RP04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THREE COMPASSES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Henry Thomas | Director | Floor Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 142764470001 | ||||
BURTON, Colin | Secretario | 14 Barnsley Road RM3 9LP Romford Essex | British | 86084200001 | ||||||
DANIELS, James | Secretario | 21 Byron Avenue South Woodford E18 2HH London | British | Accountant | 110484910001 | |||||
RAHMAN, Enamur | Secretario | Floor Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st United Kingdom | 152383090001 | |||||||
BULTITUDE, Alan | Director | 2 Chatsworth Avenue Great Notley CM77 7ZB Braintree Essex | British | Accountant | 102122400001 | |||||
HULBERT, Mark | Director | No 2 Blakes Cottage Well Long Sutton RG29 1TH Odiham | British | Managing Director | 70691150002 | |||||
KEEBLE, James Trevor | Director | Floor Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st United Kingdom | England | British | Financial Adviser | 127852330005 | ||||
RAHMAN, Enamur Ur | Director | Floor Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 158634550002 | ||||
RING, Simon Matthew | Director | The Beeches 9 Hawley Grove, Blackwater GU17 9JY Camberley Surrey | British | Accountant | 99709370001 | |||||
ROSE, Paul Clifford | Director | Mansfield Hill Chingford E4 7JU London 8 | United Kingdom | British | Director | 52815670001 | ||||
SEBBORN, Terry William | Director | The Old Post House Debtford Lane, Greywell RG29 1BZ Hook Hampshire | England | British | Director | 99709360001 | ||||
STEDMAN, Simon Christoffer | Director | 136 Glengall Road IG8 0DS Woodford Green Essex | United Kingdom | British | Accountant | 190800880001 |
¿Tiene THREE COMPASSES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Charge of deposit | Creado el 15 abr 2008 Entregado el 19 abr 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit initially of £84,000 credited to account designation 14165244 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 13 abr 2007 Entregado el 18 abr 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 145 barkham road wokingham berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 13 abr 2007 Entregado el 18 abr 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 145A barkham road wokingham berkshire and land at rear of 143, 143A, 145B, 147, 149, 151 and 153 barkham road wokingham berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 24 ene 2007 Entregado el 30 ene 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land k/a 24 chestnut avenue and land to the rear of 18,20,22 and 26 chestnut avenue wokingham t/no's BK93619, BK70393, BK109698 and BK254841. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 11 jul 2006 Entregado el 18 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The duke of york public house, 371 london road, camberley, surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 14 mar 2006 Entregado el 29 mar 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land k/a 3 beavers road farnham t/no SY489555 by way of fixed charge all rights to and interest in any insurances in respect of the property, the gross rents licence fees and other monies, all interest in and rights under any contracts or agreements and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 14 mar 2006 Entregado el 22 mar 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada £650,000 due or to become due from the company to | |
Breve descripción The f/h property k/a 3 beavers road, farnham, surrey t/no SY489555. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 09 dic 2005 Entregado el 20 dic 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción 1-5 beavers road farnham surrey the full benefit and advantage of the agreement and all the estate right title and interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 04 nov 2005 Entregado el 11 nov 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 04 nov 2005 Entregado el 11 nov 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H land k/a one beavers road farnham t/n SY572171 land k/a land adjoining 1 beavers road farnham t/n SY118948 property k/a 5 beavers road farnham t/n SY661184 all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 04 nov 2005 Entregado el 09 nov 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada £650,000 due or to become due from the company to | |
Breve descripción All F.h land k/a 1 beavers road farnham t/n SY572171 all land k/a land adjoining 1 beavers road farnham part t/n SY118948 property k/a 5 beavers road farnham t/n SY661184. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0