THREE COMPASSES LIMITED

THREE COMPASSES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHREE COMPASSES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05348152
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THREE COMPASSES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra THREE COMPASSES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    First Floor Kirkdale House
    Kirkdale Road
    E11 1HP Leytonstone
    London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THREE COMPASSES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 ago 2013
    Próximas cuentas vencen el31 may 2014
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THREE COMPASSES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Enamur Ur Rahman como director el 26 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Enamur Rahman como secretario el 26 oct 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de James Trevor Keeble como director el 26 oct 2016

    1 páginasTM01

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cambio de datos del director Mr Enamur Rahman el 31 oct 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Enamur Rahman el 31 oct 2013

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Henry Thomas Smith el 31 oct 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Enamur Rahman el 31 oct 2013

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Enamur Rahman el 31 oct 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr James Trevor Keeble el 31 oct 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr James Trevor Keeble el 15 nov 2013

    2 páginasCH01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Domicilio social registrado cambiado de * Copper House Snakes Lane East Woodford Green Essex IG8 7HX United Kingdom* el 04 nov 2013

    1 páginasAD01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 ago 2012

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Enamur Rahman el 03 may 2013

    2 páginasCH01

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 31 ene 2013

    18 páginasRP04

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 feb 2013

    Estado de capital el 16 abr 2013

    • Capital: GBP 3
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    16 abr 2013A second filed AR01 was registered on 16/04/2013

    legacy

    3 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de THREE COMPASSES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMITH, Henry Thomas
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director142764470001
    BURTON, Colin
    14 Barnsley Road
    RM3 9LP Romford
    Essex
    Secretario
    14 Barnsley Road
    RM3 9LP Romford
    Essex
    British86084200001
    DANIELS, James
    21 Byron Avenue
    South Woodford
    E18 2HH London
    Secretario
    21 Byron Avenue
    South Woodford
    E18 2HH London
    BritishAccountant110484910001
    RAHMAN, Enamur
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    Secretario
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    152383090001
    BULTITUDE, Alan
    2 Chatsworth Avenue
    Great Notley
    CM77 7ZB Braintree
    Essex
    Director
    2 Chatsworth Avenue
    Great Notley
    CM77 7ZB Braintree
    Essex
    BritishAccountant102122400001
    HULBERT, Mark
    No 2 Blakes Cottage
    Well Long Sutton
    RG29 1TH Odiham
    Director
    No 2 Blakes Cottage
    Well Long Sutton
    RG29 1TH Odiham
    BritishManaging Director70691150002
    KEEBLE, James Trevor
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Adviser127852330005
    RAHMAN, Enamur Ur
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant158634550002
    RING, Simon Matthew
    The Beeches
    9 Hawley Grove, Blackwater
    GU17 9JY Camberley
    Surrey
    Director
    The Beeches
    9 Hawley Grove, Blackwater
    GU17 9JY Camberley
    Surrey
    BritishAccountant99709370001
    ROSE, Paul Clifford
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    Director
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    United KingdomBritishDirector52815670001
    SEBBORN, Terry William
    The Old Post House
    Debtford Lane, Greywell
    RG29 1BZ Hook
    Hampshire
    Director
    The Old Post House
    Debtford Lane, Greywell
    RG29 1BZ Hook
    Hampshire
    EnglandBritishDirector99709360001
    STEDMAN, Simon Christoffer
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    Director
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritishAccountant190800880001

    ¿Tiene THREE COMPASSES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of deposit
    Creado el 15 abr 2008
    Entregado el 19 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £84,000 credited to account designation 14165244 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 2008Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 13 abr 2007
    Entregado el 18 abr 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    145 barkham road wokingham berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 abr 2007Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 13 abr 2007
    Entregado el 18 abr 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    145A barkham road wokingham berkshire and land at rear of 143, 143A, 145B, 147, 149, 151 and 153 barkham road wokingham berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 abr 2007Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 2007
    Entregado el 30 ene 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land k/a 24 chestnut avenue and land to the rear of 18,20,22 and 26 chestnut avenue wokingham t/no's BK93619, BK70393, BK109698 and BK254841. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dunbar Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ene 2007Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 11 jul 2006
    Entregado el 18 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The duke of york public house, 371 london road, camberley, surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 14 mar 2006
    Entregado el 29 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land k/a 3 beavers road farnham t/no SY489555 by way of fixed charge all rights to and interest in any insurances in respect of the property, the gross rents licence fees and other monies, all interest in and rights under any contracts or agreements and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dunbar Bank PLC
    Transacciones
    • 29 mar 2006Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 14 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £650,000 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    The f/h property k/a 3 beavers road, farnham, surrey t/no SY489555.
    Personas con derecho
    • Henry Smith
    Transacciones
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 09 dic 2005
    Entregado el 20 dic 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    1-5 beavers road farnham surrey the full benefit and advantage of the agreement and all the estate right title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dunbar Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 2005Registro de un cargo (395)
    Floating charge
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 11 nov 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personas con derecho
    • Dunbar Bank PLC
    Transacciones
    • 11 nov 2005Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 11 nov 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land k/a one beavers road farnham t/n SY572171 land k/a land adjoining 1 beavers road farnham t/n SY118948 property k/a 5 beavers road farnham t/n SY661184 all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dunbar Bank PLC
    Transacciones
    • 11 nov 2005Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 09 nov 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £650,000 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    All F.h land k/a 1 beavers road farnham t/n SY572171 all land k/a land adjoining 1 beavers road farnham part t/n SY118948 property k/a 5 beavers road farnham t/n SY661184.
    Personas con derecho
    • Henry Smith
    Transacciones
    • 09 nov 2005Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0