INTERFLORA GROUP LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | INTERFLORA GROUP LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05353312 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTERFLORA GROUP LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra INTERFLORA GROUP LIMITED?
Dirección de la sede social | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERFLORA GROUP LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERFLORA GROUP LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 04 nov 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Curzon Dunstan como secretario el 31 jul 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Craig Cooper como secretario el 31 jul 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Craig Cooper como secretario el 31 may 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Rhys John Hughes como director el 31 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Curzon Dunstan como director el 31 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Curzon Dunstan como secretario el 31 may 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms Katherine Kerr como director el 31 may 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Jeffrey Bennett como director el 31 may 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Craig Cooper como director el 31 may 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 20 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 feb 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 04 feb 2015 | 22 páginas | RP04 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INTERFLORA GROUP LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNSTAN, John Curzon | Secretario | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | 261253480001 | |||||||
BENNETT, Jeffrey | Director | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | United States | American | Company Director | 259469190001 | ||||
COOPER, Craig Bryan | Director | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | United States | American | Company Secretary/Director | 152086620001 | ||||
KERR, Katherine | Director | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | United States | American | Company Director | 259469280001 | ||||
COOPER, Craig | Secretario | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | 259476480001 | |||||||
DUNSTAN, John Curzon | Secretario | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | British | Finance Director | 137551370001 | |||||
HUGHES, Rhys John | Secretario | 13 Davies Road West Bridgford NG2 5JE Nottingham | British | Accountant | 78935800001 | |||||
SOENEN, Michael | Secretario | 3113 Woodcreek Drive Downers Grove Illinois 60515 United States Of America | American | President & Ceo | 115391940001 | |||||
INGLEBY NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham West Midlands | 39944230001 | |||||||
DUNSTAN, John Curzon | Director | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | United Kingdom | British | Finance Director | 137551370001 | ||||
FLYNN, Timothy | Director | Suite 2000 11111 Santa Monica Boulevard Los Angeles 90025 United States Of America | American | Investment Professional | 115392630001 | |||||
GOLDSTON, Mark R | Director | 21301 Burbank Blvd Woodland Hills California Ca 91367 United States | United States | Company Executive | 133404270001 | |||||
HUGHES, Rhys John | Director | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Executive | 137549770001 | ||||
HUGHES, Rhys John | Director | 13 Davies Road West Bridgford NG2 5JE Nottingham | British | Accountant | 78935800001 | |||||
RICHARDS, Stephen Wallace | Director | Mill House Farm Barkston Road Marston NG21 2HN Grantham Lincolnshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 101724740001 | ||||
SOENEN, Michael | Director | 3113 Woodcreek Drive Downers Grove Illinois 60515 United States Of America | American | President & Ceo | 115391940001 | |||||
INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Director corporativo | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham West Midlands | 39944220001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INTERFLORA GROUP LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interflora Holdings Limited | 06 abr 2016 | Interflora House Watergate NG34 7TB Sleaford Interflora House Lincs United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene INTERFLORA GROUP LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Mortgage of shares | Creado el 27 may 2005 Entregado el 07 jun 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All stock shares bonds debentures debenture stock loan stock unit trust investments certificates of deposit and other securities of any description and in whatever form all dividends interest or other distributions paid or payable in respect of them all allotments accretions offers rights benefits and advantages whatever at any time arising in respect of them all stocks shares rights money or property accruing to them or offered at any time by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of them and all cash debentures or other obligations shares stocks securities or other valuable consideration arising under the realisation of the items held. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 27 may 2005 Entregado el 07 jun 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 08 feb 2005 Entregado el 12 feb 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys and liabilities due or to become due from the company to each of the security trustee and the investors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0