LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED

LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLOYDS PROPCO NO.1 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05372227
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Grant Thornton Uk Llp 30
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NHP PROPCO LIMITED11 abr 200511 abr 2005
    CLEARPLACE LIMITED22 feb 200522 feb 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 18 abr 2016

    21 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 06 mar 2016

    41 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Cancelación total de la carga 5

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Informe de progreso del administrador hasta 06 sept 2015

    30 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 06 mar 2015

    30 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 06 sept 2014

    30 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 06 mar 2014

    29 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 18 abr 2013

    26 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 05 mar 2013

    35 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 06 mar 2012

    27 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 06 sept 2011

    31 páginas2.24B

    Domicilio social registrado cambiado de * 5 North End Road London NW11 7RJ* el 20 oct 2011

    2 páginasAD01

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2010 au 30 jun 2011

    3 páginasAA01

    Informe de progreso del administrador hasta 18 abr 2011

    27 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    legacy

    1 páginasLQ02

    Aviso de nombramiento de administrador suplente/adicional

    1 páginas2.40B

    Informe de progreso del administrador hasta 18 oct 2010

    27 páginas2.24B

    ¿Quiénes son los directivos de LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CASARI, Tracey
    Rainstrasse
    CH-8955 Oetwil An Der Limmat
    29
    Zurich
    Switzerland
    Director
    Rainstrasse
    CH-8955 Oetwil An Der Limmat
    29
    Zurich
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss146292310001
    DEN HOLLANDER, Patricia
    Wilby Road 2-17
    Lobby 9
    276306 The Tessarina
    22
    Director
    Wilby Road 2-17
    Lobby 9
    276306 The Tessarina
    22
    SingaporeIrish146292430001
    MUNTWYLER, Jean-Claude
    Steinhaldenstrasse
    CH-8002 Zurich
    63
    Switzerland
    Director
    Steinhaldenstrasse
    CH-8002 Zurich
    63
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss146292590001
    RECHSTEINER, Laurianne Karin
    Schlierenstrasse
    CH-8142 Uitikon/Waldegg
    50
    Switzerland
    Director
    Schlierenstrasse
    CH-8142 Uitikon/Waldegg
    50
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss146292610001
    DEUTSCH, Chaim
    296 Golders Green Road
    NW11 9YP London
    Secretario
    296 Golders Green Road
    NW11 9YP London
    British108073640001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Director
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DEUTSCH, Chaim Leib
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    Director
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    EnglandBritish61133060001
    GURVITZ, Joseph
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    Director
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    United KingdomBritish90042110003
    GURVITZ, Meir
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    Director
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    EnglandBritish43943590002
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Director
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Director
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Director designado
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Director
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Director
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    VECHT, Dina
    Flat 2 Stanview Court
    5 Queens Road Barnet
    NW4 2TH London
    Director
    Flat 2 Stanview Court
    5 Queens Road Barnet
    NW4 2TH London
    United KingdomBritish127487970001

    ¿Tiene LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental legal charge
    Creado el 19 nov 2008
    Entregado el 27 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the acquired property being land forming part of wellesley house, botham hall road, huddersfield and all buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 27 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession
    Creado el 29 sept 2005
    Entregado el 15 oct 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Abbeygate residential home 42 quarry road st giles road winchester hampshire t/no HP289568 addison court addison street accrington lancs t/no LA774444 and LA589003 alexandra nursing home 46 alexandra road hemel hempstead hertfordshire t/no HD368759. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Securitytrustee)
    Transacciones
    • 15 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 211 feb 2010Nombramiento de un receptor o gerente (LQ01)
    • 202 mar 2011Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (LQ02)
      • Número de expediente 2
    Mortgage and charge
    Creado el 29 sept 2005
    Entregado el 12 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from an obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that the lands and premisies situate at and k/a ardmaine nursing home, fullerton road, newry, county down folio number DN134573; all that the lands and premisessituate at and k/a chestnut lodge nursing home, 47 carrickaness road, benburb, county tyrone and comprised in folio 15505; all that the lands and premises situate at and k/a rosemary lodge/orchard manor nursing homes, 7/9 fennel road, antrim, county antrim, partly comprised in folio AN20843L (for details of further properties charged please refer to form 395) by way of first fixed charge the benefit of all agreements, all shares, rights, benefits and advantages and by way of floating charge all plant, machinery and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 12 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 13 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 01 sept 2005
    Entregado el 05 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Alexandra nursing home 46 alexandra road hemel hempstead herts, the rookery queens sq ebbw vale gwent and oak tree house (f/k/a goose green) gravel hill goose green yate bristol avon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 05 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 01 sept 2005
    Entregado el 05 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H churchfield nursing home churchfield drive rainworth mansfield notts t/nos NT304587 and NT333201. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 05 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 abr 2005
    Entregado el 15 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 15 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of mortgage/charge
    Creado el 11 abr 2005
    Entregado el 15 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Chestnut lodge nursing home 47 carrickaness road benburb county tyrone folio/n 15505, rosevale nursing home 173 moira road lisburn county antrim folio/n AM38208, rosemary lodge/orchard manor nursing homes 7-9 fennel road antrim county antrim folio/n AN20843L all f/h unregistered land, all l/h unregistered land, all registered land. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 15 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    2Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robert John Belcher
    St. Catherines Court Berkeley Place
    BS8 1BQ Bristol
    Avon
    Administrador judicial/gestor
    St. Catherines Court Berkeley Place
    BS8 1BQ Bristol
    Avon
    David John Newall
    81 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    Administrador judicial/gestor
    81 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    3
    FechaTipo
    19 abr 2010Inicio de la administración
    18 abr 2016Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Robert Harry Pick
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0