LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED

LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05452202
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VENICE GEORGE HOLDINGS LIMITED04 oct 200604 oct 2006
    GEORGE HOTEL HOLDINGS LIMITED13 may 200513 may 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    2 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital el 26 nov 2021

    • Capital: GBP 0.10
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premuim account 12/11/2021
    RES13

    Cancelación total de la carga 054522020008

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 054522020009

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    24 páginasAA

    Registro de la carga 054522020009, creada el 17 dic 2020

    24 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Gail Susan Hunter como director el 30 sept 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Geraldine Josephine Gallagher como director el 30 sept 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 13 may 2020 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 054522020006

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 054522020007

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 054522020008, creada el 10 oct 2018

    75 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    19 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant192486560001
    TROY, Anthony Gerrard
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishCeo104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Secretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    British165708440001
    CASTRO, Marcos
    45 Briavels Court
    Downshill Road
    KT18 5HP Epsom
    Surrey
    Secretario
    45 Briavels Court
    Downshill Road
    KT18 5HP Epsom
    Surrey
    British109248350002
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Secretario
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    British35994320001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secretario
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    IrishDirector185108770001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    SIDOLI, Domenico
    Cloville Hall
    Ship Road
    CM2 8XA Chelmsford
    Essex
    Secretario
    Cloville Hall
    Ship Road
    CM2 8XA Chelmsford
    Essex
    Italian64784640002
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Secretario
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    AAIM SECRETARIAL SERVICES LTD
    Fifth Floor
    55 King Street
    M2 4LQ Manchester
    Lancashire
    Secretario corporativo
    Fifth Floor
    55 King Street
    M2 4LQ Manchester
    Lancashire
    124056370001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Director
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    BritishChartered Accountant98778780002
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Director
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritishInformation Consultant35994320001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Director
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritishBanker76313640003
    ELTON, James Robert
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    Director
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    United KingdomBritishDirector55689440001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant43015720002
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandIrishFinance Director185108770001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Director
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    EnglandIrishDirector185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHuman Resources Director156206540001
    HUNTER, Gail Susan
    Principal Hotels
    11 Ripon Road
    HG1 2JA Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Principal Hotels
    11 Ripon Road
    HG1 2JA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector98567690002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Director
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    BritishBank Employee98781970001
    PAYNE, Brian John
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Director
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritishInformation Consultant38688940001
    ROBSON, Jeremy Godfrey
    The Crossways
    Corseley Road
    TN3 9RT Groombridge
    East Sussex
    Director
    The Crossways
    Corseley Road
    TN3 9RT Groombridge
    East Sussex
    BritishBanker98782450001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Flat 2 105
    United Kingdom
    Director
    Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Flat 2 105
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director106792270001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Director
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    EnglandBritishDirector106792270001
    TROY, Anthony Gerrard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    WHITTON, Robert David
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    Director
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    UkBritishDirector69537740005

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Principal Hayley Group Limited
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    06 abr 2016
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland
    Número de registro04977436
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2020
    Entregado el 17 dic 2020
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transacciones
    • 17 dic 2020Registro de una carga (MR01)
    • 17 nov 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 oct 2018
    Entregado el 11 oct 2018
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transacciones
    • 11 oct 2018Registro de una carga (MR01)
    • 17 nov 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 dic 2015
    Entregado el 03 dic 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transacciones
    • 03 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 12 oct 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 12 jun 2014
    Entregado el 18 jun 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transacciones
    • 18 jun 2014Registro de una carga (MR01)
    • 12 oct 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    English law deed of accession
    Creado el 27 feb 2013
    Entregado el 01 mar 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 01 mar 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 27 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Accession deed
    Creado el 22 dic 2011
    Entregado el 29 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 03 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession
    Creado el 19 dic 2006
    Entregado el 22 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each of the obligors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 abr 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 03 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession
    Creado el 13 sept 2006
    Entregado el 23 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Secured Parties(The Security Agent)
    Transacciones
    • 23 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share charge and floating charge
    Creado el 22 jun 2005
    Entregado el 11 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge,the investments including all rights of enforcement,floating charge,all the assets,property and undertaking of the chargor both present and future ,including all its goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 20 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0