DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05458252 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED?
- (7011) /
¿Dónde se encuentra DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED?
Dirección de la sede social | 7 Swallow Street W1B 4DE London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 may 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Raymond John Stewart Palmer como director el 14 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Civil como director el 14 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher James Taylor como director el 14 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nigel Bruce Ashfield el 16 may 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 may 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher James Taylor el 25 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nigel Bruce Ashfield el 25 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Anthony Robert Buckley el 25 feb 2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 10 Crown Place London EC2A 4FT el 01 mar 2011 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 may 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Towns como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher James Taylor como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Anthony Robert Buckley el 18 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Anthony Robert Buckley el 16 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Martin Alexander Towns el 15 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nigel Bruce Ashfield el 15 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Anthony Robert Buckley el 15 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 may 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCKLEY, Anthony Robert | Secretario | Swallow Street W1B 4DE London 7 United Kingdom | New Zealander | 103482930002 | ||||||
ASHFIELD, Nigel Bruce | Director | Swallow Street W1B 4DE London 7 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 88937170004 | ||||
COOK, Edward Giles Bradford | Secretario | 2 Marcilly Road Wandsworth SW18 2HS London | British | Accountant | 98525990002 | |||||
PAILEX SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 20 Bedford Row WC1R 4JS London | 74551790001 | |||||||
CIVIL, David | Director | 16 Millside CM24 8BL Stansted Mount Fitchet Essex | United Kingdom | British | Company Director | 36746980005 | ||||
COOK, Edward Giles Bradford | Director | 2 Marcilly Road Wandsworth SW18 2HS London | British | Accountant | 98525990002 | |||||
PALMER, Raymond John Stewart, Mr. | Director | 3 Palace Gardens Terrace W8 4SA London | United Kingdom | British | Company Director | 75286170005 | ||||
POWELL, William David | Director | Flat 9 Roscommon House 2 Lyndhurst Gardens NW3 5WP London | United Kingdom | British | Company Director | 141636150001 | ||||
ROSCROW, Peter Donald | Director | Highbury Park N5 2XE London 74 | England | Australian,British | Company Director | 40565560006 | ||||
TAYLOR, Christopher James | Director | Swallow Street W1B 4DE London 7 United Kingdom | England | British | Company Director | 123765630001 | ||||
TOWNS, Martin Alexander | Director | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 117410340004 | |||||
WALKER, Benjamin Michael | Director | 16 Park Lane East RH2 8HN Reigate Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 81730440002 | ||||
PAILEX NOMINEES LIMITED | Director corporativo | 20 Bedford Row WC1R 4JS London | 74551780001 |
¿Tiene DANESCROFT (RUGBY I) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 20 abr 2006 Entregado el 22 abr 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land at district centre site central park central park drive rugby warwickshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0