DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05472126 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
Dirección de la sede social | 4340 Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds West Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
CARE PARTNERSHIPS 25 FUNDCO 2 LIMITED | 06 jun 2005 | 06 jun 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 08 jun 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2023 | 23 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Nigel Michael Fenny como director el 01 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Emma Louise Bolton como director el 01 oct 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2022 | 23 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Philip Jonathan Harris como director el 11 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Ronald Pickering como director el 31 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2021 | 23 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr David Adrian Leedham como director el 03 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Dean Spencer como director el 03 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Jane Angela Fitch como director el 20 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Peter James Harding como director el 15 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Amit Rishi Jaysukh Thakrar como director el 15 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard John Coates como director el 30 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2020 | 24 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Amit Rishi Jaysukh Thakrar como director el 01 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Christopher Edwin Walker como director el 01 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David John Harding como director el 01 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Arthur Would como director el 01 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2019 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Mark Ronald Pickering como director el 01 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGGER-STRANGEWAY, Victoria Louise | Secretario | Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds 4340 West Yorkshire | 172862660001 | |||||||
BOLTON, Emma Louise | Director | Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds 4340 West Yorkshire | England | British | Chartered Surveyor | 204509810001 | ||||
FITCH, Jane Angela, Dr | Director | Portland Street M1 3LD Manchester 53 England | United Kingdom | British | Regional Director | 289320690001 | ||||
HARDING, Peter James, Dr | Director | Aldersgate Street EC1A 4HD London 200 England | United Kingdom | British | Director | 288230030001 | ||||
LEEDHAM, David Adrian | Director | Leads Road HU7 0DG Hull Geneva Court England | England | British | Investment Director | 44320850006 | ||||
WALKER, Christopher Edwin | Director | Aldersgate Street EC1A 4HD London 200 England | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 267835110001 | ||||
HOYLE, Stephen William | Secretario | 110 West End Avenue HG2 9BT Harrogate North Yorkshire | British | Accountant | 90826380001 | |||||
SUGDEN, Matthew | Secretario | 12 The Shroggs Steeton BD20 6TG Keighley West Yorkshire | British | 124384850002 | ||||||
TURNBULL, Brian George | Secretario | Bridale Manor Thornton-Le-Dale YO18 7SF Pickering North Yorkshire | British | 3567880001 | ||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
BAILEY, Nicola Kathryn | Director | Rivergreen Centre Aykley Heads DH1 5TS Durham City Nhs North Durham Ccg County Durham Uk | Great Britain | British | Chief Operating Officer-Ccg (Nhs) | 141076230001 | ||||
BAXTER, Mark | Director | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House Scotland | United Kingdom | British | Director | 121315740001 | ||||
BOURNE, Maurice Charles | Director | Knights Court Solihull Parkway B37 7WY Solihull 6060 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 191952460001 | ||||
BRAIN ENGLAND, Susan Maria | Director | Beech House Vicarage Gardens Birkenshaw BD11 2EF Bradford West Yorkshire | England | British | Director | 126626970001 | ||||
CHAMBERS, Michael James | Director | Piccadilly M1 2HY Manchester 111 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 156008900001 | ||||
CHAUDHRY, Yasmin | Director | The Wynd Wynyard TS22 5QE Billingham 9 Cleveland | United Kingdom | British | Chief Executive | 193109330001 | ||||
COATES, Richard John | Director | 80 London Road SE1 6LH London Skipton House England | England | British | Investment Director | 215473490001 | ||||
CROSSLEY, Hugh Barnabas | Director | Topcliffe Close Tingley WF3 1DR Wakefield Sterling House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 107284040001 | ||||
DAY, Mark | Director | Oxford Street M1 5AN Manchester Suite 2.02 Peter House England | England | British | Senior Regional Director | 157242280001 | ||||
DE LA MOTTE, Thomas | Director | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House Scotland | United Kingdom | British | Managing Director-Integrated Solutions | 173137190001 | ||||
DOBINSON, Iain | Director | Lyndhurst Road Benton NE12 9NT Newcastle Upon Tyne 9 Tyne And Wear Uk | United Kingdom | British | Accountant | 133330170001 | ||||
FENNY, Nigel Michael | Director | Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds 4340 West Yorkshire | England | British | Company Director | 155240040001 | ||||
GALLAGHER, David | Director | Durham University Science Park DH1 3YG Durham John Snow House England England | United Kingdom | British | Health Service Director | 160392710001 | ||||
GARLAND, Peter Leslie | Director | Curly Hill LS29 0DS Ilkley 140 West Yorkshire | United Kingdom | British | Civil Servant Retired | 101359640001 | ||||
HARDING, David John | Director | 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House England | England | British | Chartered Accountant | 166693370001 | ||||
HARRIS, Philip Jonathan | Director | Knights Court Solihull Parkway B37 7WY Solihull 6060 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 98885490002 | ||||
HEAVEN, Ian Christopher | Director | Acorn Park Industrial Estate Charlestown BD17 7SW Shipley Charlestown House West Yorkshire | England | English | Director Of Corporate & Shared Services | 83694740003 | ||||
HOYLE, Stephen William | Director | 110 West End Avenue HG2 9BT Harrogate North Yorkshire | England | British | Accountant | 90826380001 | ||||
HOYLE, Stephen William | Director | 110 West End Avenue HG2 9BT Harrogate North Yorkshire | England | British | Accountant | 90826380001 | ||||
HOYLE, Stephen William | Director | 110 West End Avenue HG2 9BT Harrogate North Yorkshire | England | British | Accountant | 90826380001 | ||||
JARVEY, Kevin John | Director | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7WY Solihull 6060 Knights Court Uk | England | British | Associate Director Finance | 185176610001 | ||||
JONES, Sion Laurence | Director | Charterhouse Street EC1M 6HR London 91-93 Uk | United Kingdom | English | Asset Management Director | 137554960001 | ||||
KITCHEN, John | Director | Lower Isle Isle Lane Oxenhope BD22 9QA Keighley West Yorkshire | United Kingdom | British | Building Services Manager | 83694200001 | ||||
KNIGHT, Richard Daniel | Director | Charterhouse Street EC1M 6HR London 91 United Kingdom | United Kingdom | British | Operations Director | 162323970001 | ||||
MCCLATCHEY, Robert | Director | Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds 4340 West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 157827040001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham & Tees Community Ventures Holdco 2 Limited | 06 jun 2016 | Park Approach LS15 8GB Leeds 4340 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Assignment of contracts | Creado el 09 dic 2010 Entregado el 17 dic 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All its right, title and interest in and to all benefits accruing under or in connection with any contract and all related rights see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 16 sept 2005 Entregado el 22 sept 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H land at barnard castle health centre (to be k/a 'community hospital') victoria road, barnard castle, county durham and part of adjoining richardson hospital and john street car park, john street, barnard castle t/no DU269909 together with all that f/h land formerly forming part of richardson hospital, john street, barnard castle, county durham t/no DU282587. For details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0