DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED

DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05472126
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4340 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARE PARTNERSHIPS 25 FUNDCO 2 LIMITED06 jun 200506 jun 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2024
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta25 may 2025
    Próxima declaración de confirmación vence08 jun 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta25 may 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 25 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2023

    23 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nigel Michael Fenny como director el 01 oct 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Emma Louise Bolton como director el 01 oct 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 25 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2022

    23 páginasAA

    Cese del nombramiento de Philip Jonathan Harris como director el 11 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Ronald Pickering como director el 31 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 25 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2021

    23 páginasAA

    Nombramiento de Mr David Adrian Leedham como director el 03 nov 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Dean Spencer como director el 03 nov 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Jane Angela Fitch como director el 20 oct 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter James Harding como director el 15 oct 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Amit Rishi Jaysukh Thakrar como director el 15 oct 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard John Coates como director el 30 sept 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2020

    24 páginasAA

    Nombramiento de Mr Amit Rishi Jaysukh Thakrar como director el 01 mar 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Christopher Edwin Walker como director el 01 mar 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David John Harding como director el 01 mar 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Philip Arthur Would como director el 01 mar 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2019

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Mark Ronald Pickering como director el 01 sept 2019

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JAGGER-STRANGEWAY, Victoria Louise
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    Secretario
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    172862660001
    BOLTON, Emma Louise
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    Director
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor204509810001
    FITCH, Jane Angela, Dr
    Portland Street
    M1 3LD Manchester
    53
    England
    Director
    Portland Street
    M1 3LD Manchester
    53
    England
    United KingdomBritishRegional Director289320690001
    HARDING, Peter James, Dr
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    200
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    200
    England
    United KingdomBritishDirector288230030001
    LEEDHAM, David Adrian
    Leads Road
    HU7 0DG Hull
    Geneva Court
    England
    Director
    Leads Road
    HU7 0DG Hull
    Geneva Court
    England
    EnglandBritishInvestment Director44320850006
    WALKER, Christopher Edwin
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    200
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    200
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor267835110001
    HOYLE, Stephen William
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    BritishAccountant90826380001
    SUGDEN, Matthew
    12 The Shroggs
    Steeton
    BD20 6TG Keighley
    West Yorkshire
    Secretario
    12 The Shroggs
    Steeton
    BD20 6TG Keighley
    West Yorkshire
    British124384850002
    TURNBULL, Brian George
    Bridale Manor
    Thornton-Le-Dale
    YO18 7SF Pickering
    North Yorkshire
    Secretario
    Bridale Manor
    Thornton-Le-Dale
    YO18 7SF Pickering
    North Yorkshire
    British3567880001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BAILEY, Nicola Kathryn
    Rivergreen Centre
    Aykley Heads
    DH1 5TS Durham City
    Nhs North Durham Ccg
    County Durham
    Uk
    Director
    Rivergreen Centre
    Aykley Heads
    DH1 5TS Durham City
    Nhs North Durham Ccg
    County Durham
    Uk
    Great BritainBritishChief Operating Officer-Ccg (Nhs)141076230001
    BAXTER, Mark
    2 Lochside View
    Edinburgh Park
    EH12 9DH Edinburgh
    Miller House
    Scotland
    Director
    2 Lochside View
    Edinburgh Park
    EH12 9DH Edinburgh
    Miller House
    Scotland
    United KingdomBritishDirector121315740001
    BOURNE, Maurice Charles
    Knights Court
    Solihull Parkway
    B37 7WY Solihull
    6060
    United Kingdom
    Director
    Knights Court
    Solihull Parkway
    B37 7WY Solihull
    6060
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector191952460001
    BRAIN ENGLAND, Susan Maria
    Beech House Vicarage Gardens
    Birkenshaw
    BD11 2EF Bradford
    West Yorkshire
    Director
    Beech House Vicarage Gardens
    Birkenshaw
    BD11 2EF Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector126626970001
    CHAMBERS, Michael James
    Piccadilly
    M1 2HY Manchester
    111
    United Kingdom
    Director
    Piccadilly
    M1 2HY Manchester
    111
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector156008900001
    CHAUDHRY, Yasmin
    The Wynd
    Wynyard
    TS22 5QE Billingham
    9
    Cleveland
    Director
    The Wynd
    Wynyard
    TS22 5QE Billingham
    9
    Cleveland
    United KingdomBritishChief Executive193109330001
    COATES, Richard John
    80 London Road
    SE1 6LH London
    Skipton House
    England
    Director
    80 London Road
    SE1 6LH London
    Skipton House
    England
    EnglandBritishInvestment Director215473490001
    CROSSLEY, Hugh Barnabas
    Topcliffe Close
    Tingley
    WF3 1DR Wakefield
    Sterling House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Topcliffe Close
    Tingley
    WF3 1DR Wakefield
    Sterling House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director107284040001
    DAY, Mark
    Oxford Street
    M1 5AN Manchester
    Suite 2.02 Peter House
    England
    Director
    Oxford Street
    M1 5AN Manchester
    Suite 2.02 Peter House
    England
    EnglandBritishSenior Regional Director157242280001
    DE LA MOTTE, Thomas
    2 Lochside View
    Edinburgh Park
    EH12 9DH Edinburgh
    Miller House
    Scotland
    Director
    2 Lochside View
    Edinburgh Park
    EH12 9DH Edinburgh
    Miller House
    Scotland
    United KingdomBritishManaging Director-Integrated Solutions173137190001
    DOBINSON, Iain
    Lyndhurst Road
    Benton
    NE12 9NT Newcastle Upon Tyne
    9
    Tyne And Wear
    Uk
    Director
    Lyndhurst Road
    Benton
    NE12 9NT Newcastle Upon Tyne
    9
    Tyne And Wear
    Uk
    United KingdomBritishAccountant133330170001
    FENNY, Nigel Michael
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    Director
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director155240040001
    GALLAGHER, David
    Durham University Science Park
    DH1 3YG Durham
    John Snow House
    England
    England
    Director
    Durham University Science Park
    DH1 3YG Durham
    John Snow House
    England
    England
    United KingdomBritishHealth Service Director160392710001
    GARLAND, Peter Leslie
    Curly Hill
    LS29 0DS Ilkley
    140
    West Yorkshire
    Director
    Curly Hill
    LS29 0DS Ilkley
    140
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCivil Servant Retired101359640001
    HARDING, David John
    10-11 Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    Welken House
    England
    Director
    10-11 Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    Welken House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant166693370001
    HARRIS, Philip Jonathan
    Knights Court
    Solihull Parkway
    B37 7WY Solihull
    6060
    United Kingdom
    Director
    Knights Court
    Solihull Parkway
    B37 7WY Solihull
    6060
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector98885490002
    HEAVEN, Ian Christopher
    Acorn Park Industrial Estate
    Charlestown
    BD17 7SW Shipley
    Charlestown House
    West Yorkshire
    Director
    Acorn Park Industrial Estate
    Charlestown
    BD17 7SW Shipley
    Charlestown House
    West Yorkshire
    EnglandEnglishDirector Of Corporate & Shared Services83694740003
    HOYLE, Stephen William
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishAccountant90826380001
    HOYLE, Stephen William
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishAccountant90826380001
    HOYLE, Stephen William
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    110 West End Avenue
    HG2 9BT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishAccountant90826380001
    JARVEY, Kevin John
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Solihull
    6060 Knights Court
    Uk
    Director
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Solihull
    6060 Knights Court
    Uk
    EnglandBritishAssociate Director Finance185176610001
    JONES, Sion Laurence
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    91-93
    Uk
    Director
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    91-93
    Uk
    United KingdomEnglishAsset Management Director137554960001
    KITCHEN, John
    Lower Isle
    Isle Lane Oxenhope
    BD22 9QA Keighley
    West Yorkshire
    Director
    Lower Isle
    Isle Lane Oxenhope
    BD22 9QA Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishBuilding Services Manager83694200001
    KNIGHT, Richard Daniel
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    91
    United Kingdom
    Director
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    91
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director162323970001
    MCCLATCHEY, Robert
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    Director
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4340
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director157827040001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Durham & Tees Community Ventures Holdco 2 Limited
    Park Approach
    LS15 8GB Leeds
    4340
    England
    06 jun 2016
    Park Approach
    LS15 8GB Leeds
    4340
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene DURHAM & TEES COMMUNITY VENTURES FUNDCO (NO.2) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment of contracts
    Creado el 09 dic 2010
    Entregado el 17 dic 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to all benefits accruing under or in connection with any contract and all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Finance Parties
    Transacciones
    • 17 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 16 sept 2005
    Entregado el 22 sept 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land at barnard castle health centre (to be k/a 'community hospital') victoria road, barnard castle, county durham and part of adjoining richardson hospital and john street car park, john street, barnard castle t/no DU269909 together with all that f/h land formerly forming part of richardson hospital, john street, barnard castle, county durham t/no DU282587. For details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agents for the Banks and Security Trustee for the Financeparties (Security Trustee)
    Transacciones
    • 22 sept 2005Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0