GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05474054 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TRUSHELFCO (NO.3159) LIMITED | 07 jun 2005 | 07 jun 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 dic 2020 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 dic 2019 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF el 28 ene 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 nov 2017 au 31 may 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT el 17 ago 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Zahra Peermohamed como secretario el 19 jul 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Zahra Peermohamed como secretario el 01 mar 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Roy Slocombe como secretario el 28 feb 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Roy Slocombe como director el 28 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notification de Ge Capital Investments en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 oct 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Ge Capital Investments Funding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 oct 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Ge Capital Investments Funding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 oct 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Ge Capital Corporation (Estates) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 oct 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2016 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Stewart Girling como director el 11 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Damien Ivo Karlov como director el 28 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTER, Derek | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 225848070001 | |||||
| GIRLING, Paul Stewart | Director | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 225432580001 | |||||
| BAMBER, Janine Margaret | Secretario | 105 Shepperton Road N1 3DF London | British | 117898690002 | ||||||
| BROWN, Grace | Secretario | 35 Corringham Road Wembley Park HA9 9PX Wembley Middlesex | British | 102074060001 | ||||||
| PEERMOHAMED, Zahra | Secretario | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | 243694050001 | |||||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Secretario | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | British | 55097590003 | ||||||
| TRUSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
| ABRAMSON, Christoffer | Director | 37-39 Abingdon Road Flat 2 W8 6AH London | Swedish | 98463110005 | ||||||
| BOTHA, Stephanie | Director | 5 Highbridge Wharf Highbridge SE10 9PS London | American | 116663740001 | ||||||
| BOWDEN, Matthew Neville | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183344960001 | |||||
| BRADLEY, Michael Neville Charles | Director | 17 Worfield Street SW11 4RB London | British | 62400200001 | ||||||
| BURGER, Alec | Director | 3 Adelade Road KT12 1NB Walton On Thames Surrey | British And American | 83634080006 | ||||||
| CASEY, Shay Andrew | Director | Ground Floor 69 Radipole Road SW6 5DN London | Irish | 90824990001 | ||||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 93124450002 | |||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Director | 33 Gorst Road Battersea SW11 6JB London | United Kingdom | British | 93124450002 | |||||
| GATISS, Ian William | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | England | British | 95094220003 | |||||
| HARRIS, Neil Jason | Director | Pattison Lane Woolstone MK15 0AU Milton Keynes 11 Buckinghamshire | England | British | 94095660004 | |||||
| JACOBS, Philip | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 98827150004 | |||||
| JACOBS, Philip | Director | 8 Spring Grove W4 3NH London | United Kingdom | British | 98827150004 | |||||
| JEVNE, Anne | Director | 26 Amner Road SW11 6AA London | Norwegian | 126577610001 | ||||||
| JEVNE, Anne | Director | Flat 8 70 Ironmonger Row EC1V 3QR London | Norwegian | 106807190001 | ||||||
| KARLOV, Damien Ivo | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Irish | 202318870001 | |||||
| MANCHANDA, Anupam | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark | United Kingdom | Indian | 196338510001 | |||||
| MARFLEET, Thomas | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183345010001 | |||||
| MONIR, Nicole Frances | Director | 92 Crosslands Caddington LU1 4ER Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 102866950001 | |||||
| MURFLEET, Thomas | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | British | 139856530001 | ||||||
| PEARSON, William James | Director | Graham Road Wimbledon SW19 3SL London 171 | United Kingdom | British | 133539850001 | |||||
| ROWAN, Michael G | Director | 24 Weybridge Park KT13 8SQ Weybridge Surrey | American | 116087380002 | ||||||
| SAUL, Christopher Francis Irving | Director | 11 Chepstow Villas W11 3EE London | United Kingdom | British | 106157160001 | |||||
| SINGER, Joshua David | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 82881130001 | |||||
| SINGER, Joshua David | Director | Flat 12a Salisbury Court Salisbury Avenue N3 3AH London | United Kingdom | British | 82881130001 | |||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark | United Kingdom | English | 151593900001 | |||||
| STOKER, Louise Jane | Director | 2nd Floor Flat 45 Hillfield Road, West Hampstead NW6 1QD London | British | 96079800001 | ||||||
| URIA FERNANDEZ, Manuel | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Spanish | 123133150001 | |||||
| VASILEV, Panayot Kostadinov | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | French | 163452790001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Capital Investments | 26 oct 2017 | Ashley Road 3rd Floor WA14 2DT Altrincham 1 Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ge Capital Investments Funding Limited | 19 oct 2017 | Ashley Road 3rd Floor WA14 2DT Altrincham 1 Cheshire United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ge Capital Corporation (Estates) Limited | 06 abr 2016 | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene GE COMMERCIAL FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE PROPERTIES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0