KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05480729 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
Dirección de la sede social | Part First Floor 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 14 jun 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 28 jun 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 14 jun 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Richard Vose como secretario el 06 jun 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Emeka Ikechi Ehenulo como secretario el 20 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Ian Tayler como director el 31 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Frank Manfred Schramm como director el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Bbgi Sicav S.A. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 oct 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Mr Neil Woodburn como director el 11 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Alexander John Foot como director el 11 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 28 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Andrew Brian Deacon como director el 15 sept 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Sarah Elisabeth Madeleine Favre como director el 02 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 27 páginas | AA | ||
Nombramiento de Miss Sarah Elisabeth Madeleine Favre como director el 17 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Carlos Abuin Garcia como director el 17 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 25 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSE, Richard | Secretario | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | 323808360001 | |||||||
DEACON, Andrew Brian | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | British | Portfolio Director | 209588340001 | ||||
NAAFS, Albert Hendrik | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | Netherlands | Dutch | Director | 197964340001 | ||||
TAYLER, Ian | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | British | General Manager | 198117400001 | ||||
WOODBURN, Neil Andrew | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | England | British | Investment Director | 137607780003 | ||||
EHENULO, Emeka Ikechi | Secretario | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | 180989430001 | |||||||
GATFORD, Mark Laurence | Secretario | Orestan Lane KT24 5SN Effingham Cornerway Surrey | British | Accountant | 134587070001 | |||||
SHARPE, Tim Frank | Secretario | 24 Sarum Close SO22 5LY Winchester Hampshire | British | Director | 237083390001 | |||||
TAYLER, Ian | Secretario | 3rd Floor Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead Berkshire | 169200240001 | |||||||
THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Secretario designado corporativo | Gray's Inn Road WC1X 8EB London 280 | 900023410001 | |||||||
ANDERSON, Ian Robert | Director | 123 Forest Road TN2 5BT Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Pfi Consortium Manager | 105594070001 | ||||
BAGBY, Shane | Director | 6 Chinalls Close MK18 4BQ Finmere Woodhills Buckinghamshire | United Kingdom | British | Operations Manager | 180993680001 | ||||
BRUSH, Kevin Paul | Director | 31 Copthorn Avenue EN10 7RA Broxbourne Hertfordshire | British | Chartered Surveyor | 106033400001 | |||||
CAINES, Amanda Elizabeth | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | England | British | Portfolio Director | 147840920001 | ||||
DAWSON, Nicholas Cobbett | Director | Beech House Cromwell Gardens SL7 1BG Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 3792100001 | ||||
DICKSON, Duncan Elliot | Director | Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead 3rd Floor Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 48571630001 | ||||
FAVRE, Sarah Elisabeth Madeleine | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | French | Investment Director | 261338430001 | ||||
FOOT, David Alexander John, Mr. | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | England | British | Director, Infrastructure | 245579910001 | ||||
GARCIA, Carlos Abuin | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | Spanish | Investment Executive | 245329970001 | ||||
GIBSON, John | Director | 12 Corby Close AL2 3BB St Albans Hertfordshire | British | Surveyor | 20664760002 | |||||
GRIMSON, Mark David | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | British | Credit Manager | 212020480001 | ||||
HANDFORD, Alistair John | Director | Rowleys Freith RG9 6PR Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | Civil Engineer | 58215600004 | ||||
JONES, Craig Douglas | Director | 12 Hill Street AL3 4QT St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 108035640001 | ||||
NEWTON, Robert James | Director | c/o Infrared Capital Partners Limited Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Director, Infrastructure | 295465260001 | ||||
PEERBACCUS, Yusuf Mohamed | Director | c/o Bbpi Ltd Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead 3rd Floor Berkshire | England | British | Accountant | 264514140001 | ||||
PUGH, Martin Stuart | Director | 10 Kingswood Place HP13 7SR High Wycombe | England | British | Director | 94932310003 | ||||
QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | Asset Manager | 123048390001 | ||||
SCHRAMM, Frank Manfred | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | Germany | German | Director | 192985020001 | ||||
SHARPE, Tim Frank | Director | Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead 3rd Floor Berkshire | England | British | Director | 237083390001 | ||||
SPEER, Arne | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | Germany | German | Director | 169358780001 | ||||
STRUECKER, Daniel Johannes | Director | Ligusterweg 6 40880 Ratingen Germany | German | Company Director | 143296680001 | |||||
WAYMENT, Mark Christopher | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | Asset Manager | 62992220002 | ||||
LUCIENE JAMES LIMITED | Director designado corporativo | 280 Grays Inn Road WC1X 8EB London | 900023400001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructure Investments Holdings Limited | 06 abr 2016 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Bbgi Global Infrastructure S.A. | 06 abr 2016 | Route De Treves L-2633 Senningberg 6e Luxembourg | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A floating charge and share charge | Creado el 07 oct 2005 Entregado el 14 oct 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from kent education partnership limited to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights, title benefit and interest in, to and under the junior agreements, the interest in and to all of the secured property, including all stock, shares, interest or income and the dividends, and floating charge over all other present and future assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0