KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05480729 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Part First Floor 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 14 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 28 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 14 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Ian Tayler como director el 02 feb 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Desmond Mark French como director el 02 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Katherine Victoria Morgan como director el 16 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Albert Hendrik Naafs como director el 31 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Elisabeth Helena Maria Karssemakers como director el 31 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Brian Deacon como director el 16 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Vose como secretario el 22 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cessation de Bbgi Global Infrastructure S.A. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 may 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de British Columbia Investment Management Corporation en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 may 2025 | 1 páginas | PSC02 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 29 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Richard Vose como secretario el 06 jun 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Emeka Ikechi Ehenulo como secretario el 20 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Ian Tayler como director el 31 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Frank Manfred Schramm como director el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Bbgi Sicav S.A. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 oct 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Mr Neil Woodburn como director el 11 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Alexander John Foot como director el 11 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 28 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENCH, Desmond Mark | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | Irish | 341053120001 | |||||
| KARSSEMAKERS, Elisabeth Helena Maria | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | Netherlands | Dutch | 342569980001 | |||||
| MORGAN, Katherine Victoria | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | England | British | 289756560001 | |||||
| WOODBURN, Neil Andrew | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | England | British | 137607780003 | |||||
| EHENULO, Emeka Ikechi | Secretario | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | 180989430001 | |||||||
| GATFORD, Mark Laurence | Secretario | Orestan Lane KT24 5SN Effingham Cornerway Surrey | British | 134587070001 | ||||||
| SHARPE, Tim Frank | Secretario | 24 Sarum Close SO22 5LY Winchester Hampshire | British | 237083390001 | ||||||
| TAYLER, Ian | Secretario | 3rd Floor Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead Berkshire | 169200240001 | |||||||
| VOSE, Richard | Secretario | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | 323808360001 | |||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Secretario designado corporativo | Gray's Inn Road WC1X 8EB London 280 | 900023410001 | |||||||
| ANDERSON, Ian Robert | Director | 123 Forest Road TN2 5BT Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 105594070001 | |||||
| BAGBY, Shane | Director | 6 Chinalls Close MK18 4BQ Finmere Woodhills Buckinghamshire | United Kingdom | British | 180993680001 | |||||
| BRUSH, Kevin Paul | Director | 31 Copthorn Avenue EN10 7RA Broxbourne Hertfordshire | British | 106033400001 | ||||||
| CAINES, Amanda Elizabeth | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | England | British | 147840920001 | |||||
| DAWSON, Nicholas Cobbett | Director | Beech House Cromwell Gardens SL7 1BG Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 3792100001 | |||||
| DEACON, Andrew Brian | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | British | 209588340001 | |||||
| DICKSON, Duncan Elliot | Director | Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead 3rd Floor Berkshire | United Kingdom | British | 48571630001 | |||||
| FAVRE, Sarah Elisabeth Madeleine | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | French | 261338430001 | |||||
| FOOT, David Alexander John, Mr. | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | England | British | 245579910001 | |||||
| GARCIA, Carlos Abuin | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | Spanish | 245329970001 | |||||
| GIBSON, John | Director | 12 Corby Close AL2 3BB St Albans Hertfordshire | British | 20664760002 | ||||||
| GRIMSON, Mark David | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | British | 212020480001 | |||||
| HANDFORD, Alistair John | Director | Rowleys Freith RG9 6PR Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 58215600004 | |||||
| JONES, Craig Douglas | Director | 12 Hill Street AL3 4QT St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 108035640001 | |||||
| NAAFS, Albert Hendrik | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | Netherlands | Dutch | 197964340001 | |||||
| NEWTON, Robert James | Director | c/o Infrared Capital Partners Limited Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 295465260001 | |||||
| PEERBACCUS, Yusuf Mohamed | Director | c/o Bbpi Ltd Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead 3rd Floor Berkshire | England | British | 264514140001 | |||||
| PUGH, Martin Stuart | Director | 10 Kingswood Place HP13 7SR High Wycombe | England | British | 94932310003 | |||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||
| SCHRAMM, Frank Manfred | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | Germany | German | 192985020001 | |||||
| SHARPE, Tim Frank | Director | Braywick Gate Braywick Road SL6 1DA Maidenhead 3rd Floor Berkshire | England | British | 237083390001 | |||||
| SPEER, Arne | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire United Kingdom | Germany | German | 169358780001 | |||||
| STRUECKER, Daniel Johannes | Director | Ligusterweg 6 40880 Ratingen Germany | German | 143296680001 | ||||||
| TAYLER, Ian | Director | 1 Grenfell Road SL6 1HN Maidenhead Part First Floor Berkshire | United Kingdom | British | 198117400001 | |||||
| WAYMENT, Mark Christopher | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 62992220002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KENT EDUCATION PARTNERSHIP (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Columbia Investment Management Corporation | 20 may 2025 | Pandora Avenue Victoira 750 British Columbia Canada | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Bbgi Global Infrastructure S.A. | 06 abr 2016 | Route De Treves L-2633 Senningberg 6e Luxembourg | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Holdings Limited | 06 abr 2016 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0