JMH LIFESTYLE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | JMH LIFESTYLE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05497065 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JMH LIFESTYLE LIMITED?
- Actividades de clubes deportivos (93120) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra JMH LIFESTYLE LIMITED?
Dirección de la sede social | Birch Grove Birch Grove House Birch Grove Road RH17 7BT Horsted Keynes West Sussex United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JMH LIFESTYLE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
UPLANDS ACQUISITIONS LIMITED | 08 nov 2005 | 08 nov 2005 |
IBIS (944) LIMITED | 01 jul 2005 | 01 jul 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JMH LIFESTYLE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JMH LIFESTYLE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 12 Cadogan Place, C/O R. Ward London SW1X 9PU United Kingdom a Birch Grove Birch Grove House Birch Grove Road Horsted Keynes West Sussex RH17 7BT el 08 mar 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018 | 10 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Notification de Khaled Sifri en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Sadiq Jafar en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de James Muir Hay en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Fitriani Hasuf Hay en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 07 jun 2018 | 2 páginas | PSC09 | ||
Registro de la carga 054970650002, creada el 15 ene 2018 | 45 páginas | MR01 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 dic 2017
| 3 páginas | SH01 | ||
Comptes modifiés pour une petite entreprise établis au 31 dic 2016 | 10 páginas | AAMD | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Douglas George Johnson como director el 29 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Christophe Lecharny como director el 29 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de JMH LIFESTYLE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECHARNY, Christophe | Director | Birch Grove House Birch Grove Road RH17 7BT Horsted Keynes Birch Grove West Sussex United Kingdom | United Arab Emirates | French | Vice President Finance And It | 228414520001 | ||||
SZARVAS, Gabriella | Director | Birch Grove House Birch Grove Road RH17 7BT Horsted Keynes Birch Grove West Sussex United Kingdom | United Kingdom | Hungarian | Finance Manager | 217193890001 | ||||
BARLOW, Roger | Secretario | 7 Larkhill NN10 6BG Rushden Northamptonshire | British | Finance Manager | 117445050001 | |||||
BROWN, Jonathan Macbride | Secretario | Dubai Al Wasl Road Plot 342 United Arab Emirates | 164877480001 | |||||||
LYRISTIS, Paul | Secretario | 23 Cardross Street W6 0DP London | British | Director | 108954320001 | |||||
MOODY, Anna | Secretario | Ixworth Place SW3 3QH London 37 England England | 170344750001 | |||||||
SYMINGTON, Brian William | Secretario | 25 Sweettooth Lane CW11 1BE Sandbach Cheshire | British | Accountant | 108632920002 | |||||
CR SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 41 Chalton Street NW1 1JD London First Floor | 132794610001 | |||||||
DECHERT SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 78403190002 | |||||||
BARLOW, Roger | Director | 7 Larkhill NN10 6BG Rushden Northamptonshire | British | Finance Manager | 117445050001 | |||||
CAULTON, Henry William | Director | Ixworth Place SW3 3QH London 37 England | United Kingdom | New Zealand | Director | 211076280001 | ||||
EMERSON, Peter, Dr | Director | Bridle Path NE36 0PA East Boldon Vanburgh House Tyne And Wear Uk | British | Director | 132872030001 | |||||
GARNER, Tony Mitchell | Director | Wye Dale Church Gresley DE11 9RP Swadlincote 16 Derbyshire United Kingdom | England | British | Accountant | 128077800001 | ||||
GRAHAM, Alasdair | Director | Grosvenor Crescent SW1X 7EE London 11 | British | Accountant | 133905120001 | |||||
GRAY, Andrew Philip Martello | Director | The Coach House Guildford Road Westcott RH4 3NG Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 108937650001 | ||||
HARRIS, Braden Lee | Director | Ixworth Place SW3 3QH London 37 England England | England | Australian | Regional Financial Controller | 132737230004 | ||||
JELINEK, Tom George | Director | Ixworth Place SW3 3QH London 37 England | England | British | Assistant Director | 198334400001 | ||||
JOHNSON, Douglas George | Director | Cadogan Place, C/O R. Ward SW1X 9PU London 12 United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 172334650001 | ||||
LYRISTIS, Paul | Director | 23 Cardross Street W6 0DP London | England | British | Director | 108954320001 | ||||
PHILPOTT, Robin | Director | Burberry Court 15 Etchingham Park Road N3 2DW London 10 United Kingdom | England | British | Vice President | 125660270001 | ||||
RODDIS, Nigel Mark | Director | 6 Brockham Street SE1 4HX London | United Kingdom | British | Company Executive | 69994720004 | ||||
ROSE, Philippe | Director | 302 89 Branston Street B18 6BU Birmingham | French | Director | 126809010001 | |||||
SYMINGTON, Brian William | Director | 25 Sweettooth Lane CW11 1BE Sandbach Cheshire | England | British | Accountant | 108632920002 | ||||
VON MICHEL, Benedikt Hubertus Wilhelm Friedrich-Karl | Director | Ixworth Place SW3 3QH London 37 England England | United Kingdom | German | Investment Manager | 148749490001 | ||||
DECHERT NOMINEES LIMITED | Director corporativo | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 73625410001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JMH LIFESTYLE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Sadiq Jafar | 06 abr 2016 | Birch Grove House Birch Grove Road RH17 7BT Horsted Keynes Birch Grove West Sussex United Kingdom | No |
Nacionalidad: British,Iraqi País de residencia: United Arab Emirates | |||
Naturaleza del control
| |||
Mrs Fitriani Hasuf Hay | 06 abr 2016 | Birch Grove House Birch Grove Road RH17 7BT Horsted Keynes Birch Grove West Sussex United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr James Muir Hay | 06 abr 2016 | Birch Grove House Birch Grove Road RH17 7BT Horsted Keynes Birch Grove West Sussex United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Khaled Sifri | 06 abr 2016 | Hadef & Partners Llc Building 3, Level 5, Downtown Dubai 37172 12276 Dubai Emaar Square Uae United Arab Emirates | No |
Nacionalidad: Jordanian País de residencia: United Arab Emirates | |||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para JMH LIFESTYLE LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
01 jul 2016 | 07 jun 2018 | La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene JMH LIFESTYLE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 15 ene 2018 Entregado el 16 ene 2018 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 01 ago 2013 Entregado el 05 ago 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Land. Jmh lifestyle limited charges by way of first legal mortgage with full title guarantee all freehold and leasehold property in which it has an interest both present and future, and together with all buildings and fixtures (including trade fixtures), including:. • buncton barn, buncton lane, bolney, west sussex RH17 5RE, with title number wsx 192624;. • tumworth lodge, herriard, basingstoke, hampshire; and. • lease of sporting rights at tumworth shoot.. Jmh lifestyle limited also charges by way of first fixed charge with full title guarantee all other interests, present and future, in any freehold or leasehold property, the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property, all proceeds of sale derived therefrom and the benefit of all warranties and covenants given in respect thereof and all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land.. Intellectual property. Jmh lifestyle limited charges by way of first fixed charge with full title guarantee all intellectual property rights in which it has an interest, both present and future. This does not include any intellectual property right in which jmh lifestyle limited has an interest under any licence or other agreement which either precludes absolutely or conditionally (including requiring the consent of any third party) jmh lifestyle limited from creating any charge over its interest in that intellectual property until the relevant condition or waiver has been satisfied or obtained, at which point it will become subject to the fixed charge.. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0